Actos BORME de Omega 93 Sl
24 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ PIQUERAS BARCELO ALVARO;MARTINEZ PIQUERAS BARCELO FRANCISCOJAVIER. Nombramientos. LiquiSoli: MARTINEZ PIQUERAS BARCELO FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ PIQUERAS BARCELOALVARO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 7030 , F 80, S 8, H M 114305, I/A 13 (17.01.23).
05 de Septiembre de 2012Cambio de domicilio social. C/ CABELLERA DE BERENICE 9 (MADRID). Datos registrales. T 7030 , F 80, S 8, H M 114305, I/A12 (17.08.12).
19 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ PIQUERAS BARCELO JAVIER;MARTINEZ PIQUERAS BARCELO ALVARO. Secretario:MARTINEZ PIQUERAS BARCELO JAVIER. Cons.Del.Sol: MARTINEZ PIQUERAS BARCELO JAVIER;MARTINEZ PIQUERASBARCELO ALVARO. Consejero: MARTINEZ PIQUERAS DEL NEGRO VICENTE. Presidente: MARTINEZ PIQUERAS BARCELOALVARO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ PIQUERAS BARCELO ALVARO;MARTINEZ PIQUERAS BARCELOFRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 7030 , F 80, S 8, H M 114305, I/A 11 ( 9.01.12).
21 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ PIQUERAS DEL NEGRO VICENTE. Revocaciones. Apoderado: MARTINEZPIQUERAS DEL NEGRO VICENTE. Nombramientos. Presidente: MARTINEZ PIQUERAS BARCELO ALVARO. Cambio dedomicilio social. C/ BELLATRIX 5C (MADRID). Datos registrales. T 7030 , F 79, S 8, H M 114305, I/A 10 (10.06.10).
11 de Enero de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 240.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.043.400,00 Euros. Datos registrales. T 7030 , F79, S 8, H M 114305, I/A 9 (29.12.09).
19 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BARCELO DE TORRES MARIA PILAR. Datos registrales. T 7030 , F 79, S 8, H M 114305, I/A 8 (9.02.09).