Actos BORME de Onil Obras Y Servicios Sa
18 de Agosto de 2023Nombramientos. ADM.UNICO: HERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 42473 , F 62, S 8, H B 409419,I/A 13 ( 8.08.23).
24 de Junio de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BNFIX PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42473 , F 61, S 8, H B 409419, I/A 12(17.06.22).
05 de Marzo de 2021Fe de erratas: En el BORME no.234/2020 y con referencia 428153 donde se lee (30.11.20) debe leerse (27.11.20). Datosregistrales. T 42473 , F 61, S 8, H B 409419, I/A 11 (27.11.20).
04 de Diciembre de 2020Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BNFIX PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42473 , F 61, S 8, H B 409419, I/A 11(30.11.20).
20 de Abril de 2018Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 42473 , F 61, S 8, H B 409419, I/A 10(12.04.18).
01 de Febrero de 2018Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BNFIX PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42473 , F 61, S 8, H B 409419, I/A 9(25.01.18).
17 de Enero de 2018Nombramientos. ADM.UNICO: HERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 42473 , F 60, S 8, H B 409419,I/A 8 ( 9.01.18).
06 de Septiembre de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABANTE PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42473 , F 60, S 8, H B 409419, I/A 7(25.08.16).
01 de Diciembre de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Cambio de domicilio social. AV CERDANYOLA,92-94 P.1 PTA.12 (SANT CUGAT DELVALLES). Datos registrales. T 42473 , F 60, S 8, H B 409419, I/A 6 (23.11.15).
27 de Agosto de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABANTE PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42473 , F 60, S 8, H B 409419, I/A 5(19.08.15).
25 de Agosto de 2015Fe de erratas: En el BORME no.37/2013 y con referencia 89192 RECTIFICADAS LAS CIFRAS DE CAPITAL DESEMBOLSADO YCAPITAL RESULTANTE DESEMBOLSADO EN "30.000,00" Y "210.000,00" RESPECTIVAMENTE. Datos registrales. T 42473 , F 59,S 8, H B 409419, I/A 4 (13.02.13).
22 de Febrero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 90.000,00 Euros. Desembolsado: 90.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 270.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 270.000,00 Euros. Datos registrales. T 42473 , F 59, S 8, H B 409419, I/A 4 (13.02.13).
18 de Diciembre de 2012Cambio de domicilio social. CL D'ORIENT Num.78 P.4 PTA.9 (SANT CUGAT DEL VALLES). Datos registrales. T 42473 , F 59, S8, H B 409419, I/A 3 (10.12.12).
07 de Noviembre de 2011Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LLONCH CALAFELL ESTEVE;LOPEZ LLINAS DELFIN. Nombramientos. ADM.UNICO:HERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL. Modificaciones estatutarias. RENUMERACION DEL ARTICULO 8,RELATIVO ALORGANO DE ADMINISTRACION,PASANDO A SER 8 BIS Y MODIFICACION DEL MISMO EN CUANTOA LA ESTRUCTURA DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 42473 , F 59, S 8, H B 409419, I/A 2 (26.10.11).
12 de Abril de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.02.11. Objeto social: REALIZACION POR CUENTA PROPIA Y AJENA DE TODACLASE DE OBRAS TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS,REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION,CONSERVACION YMANTENIMIENTO DE OBRAS,DIRECCION DE PROYECTOS,ETC. Domicilio: CL MAJOR DE SARRIA Num.5 P.1 PTA.1(BARCELONA). Capital suscrito: 180.000,00 Euros. Desembolsado: 180.000,00 Euros. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LLONCHCALAFELL ESTEVE;LOPEZ LLINAS DELFIN. Datos registrales. T 42473 , F 57, S 8, H B 409419, I/A 1 ( 4.04.11).