Buscador CIF Logo

Actos BORME Opade Organizacion Y Promocion De Actividades Deportivas Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Opade Organizacion Y Promocion De Actividades Deportivas Sa

Actos BORME Opade Organizacion Y Promocion De Actividades Deportivas Sa - A79858882

Tenemos registrados 83 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Opade Organizacion Y Promocion De Actividades Deportivas Sa con CIF A79858882

🔙 Perfil de Opade Organizacion Y Promocion De Actividades Deportivas Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Opade Organizacion Y Promocion De Actividades Deportivas Sa

05 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PALACIN RIZO RAFAEL. Apo.Sol.: PALACIN RIZO RAFAEL. Datos registrales. T 42341 , F 49, S 8,H M 14582, I/A 108 (29.08.23).

03 de Mayo de 2023
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42341 , F 49, S 8, H M 14582, I/A 107 (24.04.23).

21 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: ARCE ARGOS LUIS FERNANDO;ABANADES JIMENEZ SERGIO. Datos registrales. T 42341 , F 48,S 8, H M 14582, I/A 106 (13.03.23).

02 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: LOZANO PUEYO EPIFANIO. Apo.Sol.: MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL. Apoderado: ESPADAMONZON JOSE ENRIQUE;MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;AGUDO SAIZ JULIO;MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;ESPADAMONZON JOSE ENRIQUE;MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;ESPADA MONZON JOSE ENRIQUE;MERINERO PECO VICTORIAISABEL. Datos registrales. T 42341 , F 48, S 8, H M 14582, I/A 105 (23.02.23).

07 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: LOZANO PUEYO EPIFANIO;GARCIA DOMENECH JOSE-LUIS;GONZALEZ WIEDMAIER JUANCRISTOBAL;AGUDO SAIZ JULIO;MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;ESPADA MONZON JOSE ENRIQUE;MERINERO PECOVICTORIA ISABEL;CAMBA LOPEZ MARIA. Datos registrales. T 42341 , F 45, S 8, H M 14582, I/A 104 (29.11.22).

06 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: ABRIL MARTIN MARCIAL. Apoderado: ABRIL MARTIN MARCIAL;ABRIL MARTIN MARCIAL;ABRILMARTIN MARCIAL. Datos registrales. T 42341 , F 45, S 8, H M 14582, I/A 103 (29.09.22).

04 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: DE HOYOS PEREZ ALFONSO. Apo.Manc.: DE HOYOS PEREZ ALFONSO. Datos registrales. T 42341, F 44, S 8, H M 14582, I/A 102 (25.02.22).

16 de Febrero de 2022
Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42341 , F 44, S 8,H M 14582, I/A 101 ( 9.02.22).

24 de Agosto de 2021
Reelecciones. Representan: GARCIA IGLESIAS LUIS FRANCISCO. Adm. Unico: COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA. Datosregistrales. T 22988 , F 74, S 8, H M 14582, I/A 100 (17.08.21).

10 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MOLINA NOELIA. Datos registrales. T 22988 , F 74, S 8, H M 14582, I/A 99 ( 3.06.21).

05 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: RAMIREZ LOPEZ PEDRO. Apo.Manc.: RAMIREZ LOPEZ PEDRO;RAMIREZ LOPEZ PEDRO. Datosregistrales. T 22988 , F 74, S 8, H M 14582, I/A 97 (26.02.21).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ IPIÑA JAVIER. Datos registrales. T 22988 , F 74, S 8, H M 14582, I/A 98 (26.02.21).

08 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MANJON LINARES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: MANJON LINARES JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 22988 , F 73, S 8, H M 14582, I/A 96 ( 1.09.20).

27 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apoderado: MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;ESPADA MONZON JOSE ENRIQUE;ABRIL MARTINMARCIAL;MERINERO PECO VICTORIA ISABEL. Datos registrales. T 22988 , F 72, S 8, H M 14582, I/A 95 (20.05.20).

04 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL;JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T22988 , F 72, S 8, H M 14582, I/A 94 (24.04.20).

28 de Febrero de 2020
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 22988 , F 71, S 8, H M 14582, I/A 93 (21.02.20).

10 de Enero de 2020
Nombramientos. Apoderado: ABANADES JIMENEZ SERGIO. Datos registrales. T 22988 , F 71, S 8, H M 14582, I/A 92 ( 2.01.20).

17 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ SOBRINO OSCAR. Apoderado: SANCHEZ SOBRINO OSCAR. Datos registrales. T 22988 , F70, S 8, H M 14582, I/A 91 (10.12.19).

11 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SALVIEJO DE DIEGO PABLO. Datos registrales. T 22988 , F 70, S 8, H M 14582, I/A 89 ( 4.10.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNAN DEL CAMPO JACOBO RAMON. Datos registrales. T 22988 , F 70, S 8, H M 14582, I/A 90 (4.10.19).

12 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: BERMUDEZ PEREZ TOMAS. Apoderado: BERMUDEZ PEREZ TOMAS;BERMUDEZ PEREZ CHUECOSTOMAS. Datos registrales. T 22988 , F 70, S 8, H M 14582, I/A 88 ( 5.08.19).

06 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apoderado: MACHUCA MOROCHO ROMAYSA MARINA. Datos registrales. T 22988 , F 70, S 8, H M 14582, I/A87 (30.07.19).

05 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: ABAD SALMERON ALVARO. Datos registrales. T 22988 , F 69, S 8, H M 14582, I/A 85 (29.01.19).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ IPIÑA JAVIER. Datos registrales. T 22988 , F 69, S 8, H M 14582, I/A 86 (29.01.19).

05 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 69, S 8, H M 14582, I/A 84 (26.11.18).

10 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apoderado: ABANADES JIMENEZ SERGIO. Datos registrales. T 22988 , F 69, S 8, H M 14582, I/A 83 ( 3.08.18).

26 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: ABAD SALMERON ALVARO. Datos registrales. T 22988 , F 68, S 8, H M 14582, I/A 81 (19.06.18).

Revocaciones. Apoderado: ABAD SALMERON FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 22988 , F 68, S 8, H M 14582, I/A 82(19.06.18).

14 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL;ABRIL MARTINMARCIAL;BERMUDEZ PEREZ CHUECOS TOMAS;ESPADA MONZON JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 22988 , F 66, S 8, HM 14582, I/A 80 ( 7.05.18).

23 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: MONTERDE PEREZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 22988 , F 66, S 8, H M 14582, I/A 79(16.04.18).

16 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: REIN ROJO LUIS. Nombramientos. Representan: GARCIA IGLESIAS LUIS FRANCISCO. Datosregistrales. T 22988 , F 66, S 8, H M 14582, I/A 78 ( 9.04.18).

27 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: CARRAL LLERA JESUS. Apo.Sol.: CARRAL LLERA JESUS. Datos registrales. T 22988 , F 66, S 8, HM 14582, I/A 77 (19.02.18).

01 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: BONET GAMBINS ANTONI. Apo.Sol.: BONET GAMBINS ANTONI. Datos registrales. T 22988 , F 65, S8, H M 14582, I/A 76 (23.01.18).

11 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNAN DEL CAMPO JACOBO RAMON. Datos registrales. T 22988 , F 65, S 8, H M 14582, I/A75 ( 3.01.18).

18 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 65, S 8, H M 14582, I/A 74 ( 9.12.17).

03 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ NICOLAS ROBERTO MATEO. Datos registrales. T 22988 , F 65, S 8, H M 14582, I/A 73(25.09.17).

30 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: AGUDO SAIZ JULIO. Datos registrales. T 22988 , F 64, S 8, H M 14582, I/A 72 (21.06.17).

09 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL;JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T22988 , F 63, S 8, H M 14582, I/A 71 (30.05.17).

20 de Abril de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ GONZALEZ-UBEDA IGNACIO. Datos registrales. T 22988 , F 62, S 8, H M 14582, I/A 70(10.04.17).

10 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS. Datos registrales. T 22988 , F 62, S 8, H M 14582, I/A 69 (28.02.17).

22 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LEAL HERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 22988 , F 62, S 8, H M 14582, I/A 68 (14.02.17).

08 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: BURGOS GOMEZ JOSE;CARPI CUCALON ANTONIO;JUST RODRIGO ALEJANDRO;PALACIN RIZORAFAEL;RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL FERNANDO;BONET GAMBINS ANTONI;CARRAL LLERA JESUS;MANJON LINARESJOSE MANUEL;SIMON SANZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 22988 , F 61, S 8, H M 14582, I/A 67 ( 1.02.17).

29 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 61, S 8, H M 14582, I/A 66 (20.12.16).

15 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUST RODRIGO ALEJANDRO;BURGOS GOMEZ JOSE. Datos registrales. T 22988 , F 61, S 8, HM 14582, I/A 65 ( 7.09.16).

27 de Junio de 2016
Reelecciones. Adm. Unico: COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA. Representan: REIN ROJO LUIS. Datos registrales. T 22988 , F60, S 8, H M 14582, I/A 64 (17.06.16).

16 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apoderado: BONET GAMBINS ANTONI;BURGOS GOMEZ JOSE. Datos registrales. T 22988 , F 60, S 8, H M14582, I/A 62 ( 8.03.16).

Revocaciones. Apoderado: PICADO RUIZ ANDRES MARIA. Apo.Man.Soli: FERRER ARBONA MARTIN. Datos registrales. T22988 , F 60, S 8, H M 14582, I/A 63 ( 8.03.16).

02 de Marzo de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 59, S 8, H M 14582, I/A 61 (24.02.16).

25 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apoderado: ARCE ARGOS LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 22988 , F 59, S 8, H M 14582, I/A 60(16.02.16).

04 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ACOSTA MELLADO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 22988 , F 59, S 8, H M 14582, I/A 59(27.01.15).

02 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS;BURGOS GOMEZ JOSE. Datos registrales. T 22988 , F 58, S 8, HM 14582, I/A 58 (23.01.15).

08 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON. Nombramientos. Representan: REIN ROJO LUIS. Datosregistrales. T 22988 , F 58, S 8, H M 14582, I/A 57 (29.12.14).

16 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 58, S 8, H M 14582, I/A 56 ( 9.10.14).

20 de Marzo de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 57, S 8, H M 14582, I/A 54 (12.03.14).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ CORDOBA FERNANDO. Datos registrales. T 22988 , F 58, S 8, H M 14582, I/A 55(13.03.14).

06 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL FERNANDO;CARRAL LLERA JESUS;BURGOS GOMEZ JOSE.Datos registrales. T 22988 , F 57, S 8, H M 14582, I/A 53 (29.01.14).

22 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ GONZALEZ-UBEDA IGNACIO. Datos registrales. T 22988 , F 56, S 8, H M 14582, I/A 52(14.11.13).

29 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: FANJUL PASTRANA JUAN JOSE. Nombramientos. Representan: JIMENEZ SERRANORAMON. Datos registrales. T 22988 , F 56, S 8, H M 14582, I/A 51 (21.08.13).

23 de Abril de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 56, S 8, H M 14582, I/A 50 (12.04.13).

18 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: FUENTE VILLAR JOSE LUIS;CARPI CUCALON ANTONIO;ACOSTA MELLADO MIGUEL ANGEL;PALACINRIZO RAFAEL;SALVIEJO DE DIEGO PABLO;FERRER ARBONA MARTIN;SAGASTA PELLICER JOSE MARIA;BURGOS GOMEZJOSE;LEAL HERNANDEZ ENRIQUE;FUENTES VILLAR JOSE LUIS;CARPI CUCALON ANTONIO;ACOSTA MELLADO MIGUELANGEL;PALACIN RIZO RAFAEL;SALVIEJO DE DIEGO PABLO;FERRER ARBONA MARTIN;SAGASTA PELLICER JOSEMARIA;BURGOS GOMEZ JOSE;LEAL HERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 22988 , F 56, S 8, H M 14582, I/A 49(10.04.13).

22 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEAL HERNANDEZ ENRIQUE;CARPI CUCALON ANTONIO;ACOSTA MELLADO MIGUELANGEL;PALACIN RIZO RAFAEL;FERRER ARBONA MARTIN;SALVIEJO DE DIEGO PABLO;FUENTE VILLAR JOSE LUIS;MANJONLINARES JOSE MANUEL;SIMON SANZ JUAN CARLOS;JIMENEZ CORDOBA FERNANDO;BURGOS GOMEZ JOSE. Datosregistrales. T 22988 , F 55, S 8, H M 14582, I/A 48 (14.02.13).

21 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ LOPEZ PEDRO. Datos registrales. T 22988 , F 55, S 8, H M 14582, I/A 47 (13.12.12).

05 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: ABAD SALMERON FRANCISCO BORJA;GONZALEZ NICOLAS ROBERTO MATEO. Datosregistrales. T 22988 , F 54, S 8, H M 14582, I/A 45 (22.08.12).

Revocaciones. Apoderado: ABAD SALMERON FRANCISCO BORJA;MATEO GONZALEZ NICOLAS ROBERTO. Datos registrales.T 22988 , F 55, S 8, H M 14582, I/A 46 (22.08.12).

14 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: FUENTES VILLAR JOSE LUIS;CARPI CUCALON ANTONIO;ACOSTA MELLADO MIGUELANGEL;PALACIN RIZO RAFAEL;SALVIEJO DE DIEGO PABLO;FERRER ARBONA MARTIN;SAGASTA PELLICER JOSEMARIA;BURGOS GOMEZ JOSE;LEAL HERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 22988 , F 54, S 8, H M 14582, I/A 44 ( 1.06.12).

19 de Abril de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: FUENTE VILLAR JOSE LUIS;CARPI CUCALON ANTONIO;ACOSTA MELLADO MIGUELANGEL;PALACIN RIZO RAFAEL;SALVIEJO DE DIEGO PABLO;FERRER ARBONA MARTIN;SAGASTA PELLICER JOSEMARIA;BURGOS GOMEZ JOSE;LEAL HERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 22988 , F 53, S 8, H M 14582, I/A 43 ( 2.04.12).

11 de Abril de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 53, S 8, H M 14582, I/A 42 (27.03.12).

23 de Marzo de 2012
Reelecciones. Adm. Unico: COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA. Representan: FANJUL PASTRANA JUAN JOSE. Datosregistrales. T 22988 , F 53, S 8, H M 14582, I/A 41 ( 9.03.12).

27 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: BERMUDEZ PEREZ TOMAS;ESPADA MONZON JOSE ENRIQUE;ABRIL MARTIN MARCIAL. Datosregistrales. T 22988 , F 52, S 8, H M 14582, I/A 40 (14.07.11).

13 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: MATEO GONZALEZ NICOLAS ROBERTO. Datos registrales. T 22988 , F 50, S 8, H M 14582, I/A 39( 1.06.11).

09 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA RAFAEL. Apoderado: GONZALEZ GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 22988 , F50, S 8, H M 14582, I/A 38 (26.04.11).

15 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GARCIA RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GARCIA RAFAEL. Datosregistrales. T 22988 , F 50, S 8, H M 14582, I/A 37 ( 3.03.11).

11 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 50, S 8, H M 14582, I/A 36 ( 2.02.11).

29 de Diciembre de 2010
Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA, NUMERO 10 (MADRID). Datos registrales. T 22988 , F 49, S 8,H M 14582, I/A 35 (17.12.10).

23 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: LLORENTE GOMEZ EUGENIO BARTOLOME. Nombramientos. Representan: FANJULPASTRANA JUAN JOSE. Datos registrales. T 22988 , F 49, S 8, H M 14582, I/A 34 (13.12.10).

04 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: ABAD SALMERON FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 22988 , F 48, S 8, H M 14582, I/A 33(22.09.10).

04 de Junio de 2010
Nombramientos. Apoderado: MONTERDE PEREZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 22988 , F 47, S 8, H M 14582, I/A 31(24.05.10).

Revocaciones. Apoderado: ZAMBRANA CONTRERAS IGNACIO. Apo.Sol.: GIL ROYO VICENTE. Datos registrales. T 22988 , F48, S 8, H M 14582, I/A 32 (24.05.10).

18 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA. Datos registrales. T 22988 , F 47, S 8, H M 14582, I/A 30 ( 9.03.10).

02 de Marzo de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22988 , F 47, S 8, H M 14582, I/A 29 (18.02.10).

18 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SOBRINO OSCAR. Datos registrales. T 22988 , F 46, S 8, H M 14582, I/A 28 ( 7.12.09).

29 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apoderado: PORTERO AZORIN JOSE LUIS. Datos registrales. T 22988 , F 45, S 8, H M 14582, I/A 26 (19.05.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SOBRINO OSCAR;MAGRO VALENCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 22988 , F 45,S 8, H M 14582, I/A 27 (19.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información