Actos BORME de Opde O&m Sl
30 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: CID SUAREZ LUIS;COLLANTES MORALES TOMAS;BERMUDEZ MORENO MARTA;FERNANDEZGRANADOS JESUS. Datos registrales. T 41483 , F 110, S 8, H M 735064, I/A 6 (23.06.22).
20 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: CID SUAREZ LUIS;MERA JABBOUR LEIXANDRE;FERNANDEZ GRANADOS JESUS. Datosregistrales. T 41483 , F 109, S 8, H M 735064, I/A 5 (11.04.22).
08 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: CLAROS TOBAR BEVERLY PATRICIA. Nombramientos. Apoderado: PINILLOS LOPEZ SANDRA.Datos registrales. T 41483 , F 108, S 8, H M 735064, I/A 4 ( 1.02.22).
09 de Julio de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: OPDENERGY SA. Datos registrales. T 41483 , F 108, S 8, H M735064, I/A 3 ( 2.07.21).
10 de Marzo de 2021Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 42 - 5ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 41483 , F 108,S 8, H M 735064, I/A 2 ( 3.03.21).
01 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: GARBAYO LIÑAN SILVIA. Datos registrales. T 1513 , F 55, S 8, H NA 30063, I/A 12 (23.07.18).
Nombramientos. Apoderado: CLAROS TOBAR BEVERLY PATRICIA. Datos registrales. T 1513 , F 55, S 8, H NA 30063, I/A 13(23.07.18).
23 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: REINOSO CASADO JESUS MARIA;REINOSO CASADO JESUS MARIA;GARBAYO LIÑAN SILVIA.Datos registrales. T 1513 , F 54, S 8, H NA 30063, I/A 11 (11.03.16).
26 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MIERES ROYO JOSE ANTONIO;CHAVES MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER. Nombramientos.Adm. Unico: CHAVES MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradoressolidarios a Administrador único. Datos registrales. T 1513 , F 54, S 8, H NA 30063, I/A 10 (18.01.16).
09 de Octubre de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: OPDE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES SL. Datos registrales.T 1513 , F 53, S 8, H NA 30063, I/A 9 (26.09.13).