Actos BORME de Opentrends Solucions I Sistemes Sl
01 de Agosto de 2023Cambio de denominaci贸n social. SEIDOR OPENTRENDS S.L. Datos registrales. T 36647 , F 116, S 8, H B 281356, I/A 27(25.07.23).
03 de Enero de 2023Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL. Datos registrales. T 36647 , F 116, S 8, H B 281356, I/A 26(27.12.22).
23 de Diciembre de 2022Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE;NEGRETE DEL CERRO JORDI. Datos registrales. T 36647, F 116, S 8, H B 281356, I/A 25 (16.12.22).
20 de Octubre de 2022Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE;BUSCALLA ANGLERILL FRANCESC XAVIER;NEGRETEDEL CERRO JORDI;BENITO MONTERO ANNA;BENITO MARTINEZ JOSEP. Datos registrales. T 36647 , F 113, S 8, H B 281356,I/A 22 (13.10.22).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE;BUSCALLA ANGLERILL FRANCESC XAVIER;BENITOMONTERO ANNA;MADRID BAREA PERE. Datos registrales. T 36647 , F 114, S 8, H B 281356, I/A 23 (13.10.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE;NEGRETE DEL CERRO JORDI. Datos registrales. T 36647, F 115, S 8, H B 281356, I/A 24 (13.10.22).
05 de Octubre de 2022Revocaciones. CONSEJERO: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE. CONS. DELEG.: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE.CONSEJERO: BUSCALLA ANGLERILL FRANCESC XAVIER;PUGA MOURE CARLOS JUAN;NEGRETE DEL CERRO JORDI.SECRETARIO: NEGRETE DEL CERRO JORDI. PRESIDENTE: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE. Nombramientos. CONSEJERO:BENITO MARTINEZ JOSEP. PRESIDENTE: BENITO MARTINEZ JOSEP. CONSEJERO: ANGUERA SOLSONASANTIAGO;BARRERA BOSCH JOAN RAMON;GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE. SECRETARIO: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE.CONSEJERO: BUSCALLA ANGLERILL FRANCESC XAVIER. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS7c),17,19 y 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 36647 , F 112, S 8, H B 281356, I/A 21 (28.09.22).
31 de Agosto de 2022Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ SANCHEZ JUAN JOSE;BUSCALLA ANGLERILL FRANCESC XAVIER. Datosregistrales. T 36647 , F 111, S 8, H B 281356, I/A 20 (24.08.22).
22 de Agosto de 2019Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CASTELLA AUDITORS CONSULTORS SLP. Datos registrales. T 36647 , F 111, S 8, H B281356, I/A 19 (14.08.19).
04 de Enero de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CASTELLA AUDITORS CONSULTORS SLP. Datos registrales. T 36647 , F 110, S 8, H B281356, I/A 18 (28.12.16).
17 de Junio de 2016Cambio de domicilio social. CL VENECUELA Num.105 P.4 (BARCELONA). Datos registrales. T 36647 , F 110, S 8, H B 281356,I/A 17 ( 9.06.16).
28 de Diciembre de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30.298,00 Euros. Resultante Suscrito: 149.822,00 Euros. Datos registrales. T 36647 , F110, S 8, H B 281356, I/A 16 (17.12.15).
04 de Diciembre de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MONCUNILL AUDITORS SL. Datos registrales. T 36647 , F 109, S 8, H B 281356, I/A 15(26.11.15).
22 de Mayo de 2015Modificaciones estatutarias. ADICION ART.6 BIS: PRESTACION ACCESORIA. Datos registrales. T 36647 , F 109, S 8, H B281356, I/A 14 (12.05.15).
31 de Diciembre de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MONCUNILL AUDITORS SL. Datos registrales. T 36647 , F 109, S 8, H B 281356, I/A 13(23.12.14).
12 de Marzo de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MONCUNILL AUDITORS SL. Datos registrales. T 36647 , F 109, S 8, H B 281356, I/A 12 (3.03.14).
18 de Abril de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MONCUNILL AUDITORS SL. Datos registrales. T 36647 , F 108, S 8, H B 281356, I/A 11(12.04.13).
18 de Febrero de 2013Cambio de domicilio social. CL VENECUELA,NUMERO 105, 1-A (BARCELONA). Datos registrales. T 36647 , F 108, S 8, H B281356, I/A 10 ( 8.02.13).
22 de Mayo de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MONCUNILL BRUGUERA JOSEP. Datos registrales. T 36647 , F 108, S 8, H B 281356, I/A 9 (6.05.09).