Actos BORME de Operadores Portuarios Santa Pola Sl
24 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO JORGE. Apo.Sol.: MARTIN FRANCO JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: VITALURGOITI CARLOS;PEREZ LOPEZ ELENA MARIA;CUTANDA ESCRIBANO MARIA. Apo.Manc.: VITAL URGOITI CARLOS;PEREZLOPEZ ELENA MARIA;CUTANDA ESCRIBANO MARIA. Datos registrales. T 3263 , F 176, S 8, H A 109357, I/A 24 (16.08.23).
16 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Apo.Manc.: AGUIRRE AGUIRREZABALJUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJOANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Datos registrales. T 3263 , F 176, S 8, H A 109357, I/A 22 ( 5.11.21).
14 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZLARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL;MARTIN FRANCO JORGE. Apo.Manc.: AGUIRREAGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELATELLEZ MARTA ISABEL;MARTIN FRANCO JORGE. Datos registrales. T 3263 , F 176, S 8, H A 109357, I/A 21 ( 6.05.21).
16 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 3263 , F 126, S 8, H A 109357, I/A 19 (7.12.20).
15 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANDRES. Datos registrales. T 3263 , F 126, S 8, H A 109357, I/A 18 (3.12.20).
29 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDEZ MORENO EMILIO. Datos registrales. T 3263 , F 126, S 8, H A 109357, I/A 17 (21.11.18).
10 de Mayo de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 282.412,62 Euros. Resultante Suscrito: 309.647,38 Euros. Datos registrales. T 3263 , F126, S 8, H A 109357, I/A 15 (29.04.16).
07 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Nombramientos. SecreNoConsj: MENENDEZ SANZALBERTO. Datos registrales. T 3263 , F 125, S 8, H A 109357, I/A 13 (30.07.14).
27 de Mayo de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 586.660,00 Euros. Resultante Suscrito: 592.060,00 Euros. Datos registrales. T 3263 , F 125, S 8, HA 109357, I/A 12 (19.05.14).
14 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Datos registrales. T 3263 , F 125, S 8, H A 109357, I/A 11(23.04.13).
30 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Apo.Manc.: AGUIRRE AGUIRREZABALJUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJOANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Datos registrales. T 3237 , F 118, S 8, H A 109357, I/A 10 (19.04.13).
26 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTESINOS CAPELO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: FUSTER TOME PABLOCRISANTO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 600,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.400,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo 10潞.- Convocatoria de la junta. Datos registrales. T 3237 , F 118, S 8, H A 109357, I/A 9 (18.04.13).
20 de Octubre de 2010Fe de erratas: La fecha correcta del nombramiento de la mercantil BERGE MARITIMA SL como consejero delegado es 24 de julio de2009 y no 2 de abril de 2009 como se hizo constar por error. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8, H A 109357, I/A 3 (14.12.09).
09 de Junio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: CABALLERO DAVILA ROSA;BELLO POMARES FRANCISCO. Datos registrales. T 3237 , F 118, S 8, HA 109357, I/A 8 (28.05.10).
08 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: CABALLERO DAVILA ROSA;HERNANDEZ MORENO EMILIO. Datos registrales. T 3237 , F 117, S 8,H A 109357, I/A 7 (26.05.10).
12 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANDRES. Datos registrales. T 3237 , F 33, S 8, H A 109357, I/A 6(30.12.09).
29 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: CABALLERO DAVILA ROSA;BELLO POMARES FRANCISCO. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8,H A 109357, I/A 4 (15.12.09).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ TORRALBA MANUEL JUAN. Datos registrales. T 3237 , F 32, S 8, H A 109357, I/A 5(16.12.09).
24 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MONTESINOS CAPELO FRANCISCO;FUSTER TASA FELIPE ANDRES. Nombramientos.Consejero: BERGE MARITIMA SL;FUSTER TASA FELIPE ANDRES;MONTESINOS CAPELO FRANCISCO;BERGEINFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS INTE;CASACOBOS GESTION SL;FUSTER TOME FELIPE. Presidente: BERGEMARITIMA SL. Vicepresid.: FUSTER TASA FELIPE ANDRES. VsecrNoConsj: MU脩OZ DE VERGER GARCIA ANTONIO.SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Con.Delegado: BERGE MARITIMA SL. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8, H A109357, I/A 3 (14.12.09).
23 de Diciembre de 2009Modificaciones estatutarias. Art铆culo 12潞.- Administraci贸n y Representaci贸n.. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8, H A 109357, I/A2 (14.12.09).