Buscador CIF Logo

Actos BORME Operadores Portuarios Santa Pola Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Operadores Portuarios Santa Pola Sl

Actos BORME Operadores Portuarios Santa Pola Sl - B54288261

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Operadores Portuarios Santa Pola Sl con CIF B54288261

馃敊 Perfil de Operadores Portuarios Santa Pola Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Operadores Portuarios Santa Pola Sl

24 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO JORGE. Apo.Sol.: MARTIN FRANCO JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: VITALURGOITI CARLOS;PEREZ LOPEZ ELENA MARIA;CUTANDA ESCRIBANO MARIA. Apo.Manc.: VITAL URGOITI CARLOS;PEREZLOPEZ ELENA MARIA;CUTANDA ESCRIBANO MARIA. Datos registrales. T 3263 , F 176, S 8, H A 109357, I/A 24 (16.08.23).

16 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Apo.Manc.: AGUIRRE AGUIRREZABALJUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJOANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Datos registrales. T 3263 , F 176, S 8, H A 109357, I/A 22 ( 5.11.21).

14 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZLARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL;MARTIN FRANCO JORGE. Apo.Manc.: AGUIRREAGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELATELLEZ MARTA ISABEL;MARTIN FRANCO JORGE. Datos registrales. T 3263 , F 176, S 8, H A 109357, I/A 21 ( 6.05.21).

16 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 3263 , F 126, S 8, H A 109357, I/A 19 (7.12.20).

15 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANDRES. Datos registrales. T 3263 , F 126, S 8, H A 109357, I/A 18 (3.12.20).

29 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDEZ MORENO EMILIO. Datos registrales. T 3263 , F 126, S 8, H A 109357, I/A 17 (21.11.18).

10 de Mayo de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 282.412,62 Euros. Resultante Suscrito: 309.647,38 Euros. Datos registrales. T 3263 , F126, S 8, H A 109357, I/A 15 (29.04.16).

07 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Nombramientos. SecreNoConsj: MENENDEZ SANZALBERTO. Datos registrales. T 3263 , F 125, S 8, H A 109357, I/A 13 (30.07.14).

27 de Mayo de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 586.660,00 Euros. Resultante Suscrito: 592.060,00 Euros. Datos registrales. T 3263 , F 125, S 8, HA 109357, I/A 12 (19.05.14).

14 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Datos registrales. T 3263 , F 125, S 8, H A 109357, I/A 11(23.04.13).

30 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Apo.Manc.: AGUIRRE AGUIRREZABALJUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJOANDRES;ZAVALA FERNANDEZ GORKA. Datos registrales. T 3237 , F 118, S 8, H A 109357, I/A 10 (19.04.13).

26 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTESINOS CAPELO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: FUSTER TOME PABLOCRISANTO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 600,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.400,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo 10潞.- Convocatoria de la junta. Datos registrales. T 3237 , F 118, S 8, H A 109357, I/A 9 (18.04.13).

20 de Octubre de 2010
Fe de erratas: La fecha correcta del nombramiento de la mercantil BERGE MARITIMA SL como consejero delegado es 24 de julio de2009 y no 2 de abril de 2009 como se hizo constar por error. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8, H A 109357, I/A 3 (14.12.09).

09 de Junio de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: CABALLERO DAVILA ROSA;BELLO POMARES FRANCISCO. Datos registrales. T 3237 , F 118, S 8, HA 109357, I/A 8 (28.05.10).

08 de Junio de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: CABALLERO DAVILA ROSA;HERNANDEZ MORENO EMILIO. Datos registrales. T 3237 , F 117, S 8,H A 109357, I/A 7 (26.05.10).

12 de Enero de 2010
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANDRES. Datos registrales. T 3237 , F 33, S 8, H A 109357, I/A 6(30.12.09).

29 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: CABALLERO DAVILA ROSA;BELLO POMARES FRANCISCO. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8,H A 109357, I/A 4 (15.12.09).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ TORRALBA MANUEL JUAN. Datos registrales. T 3237 , F 32, S 8, H A 109357, I/A 5(16.12.09).

24 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MONTESINOS CAPELO FRANCISCO;FUSTER TASA FELIPE ANDRES. Nombramientos.Consejero: BERGE MARITIMA SL;FUSTER TASA FELIPE ANDRES;MONTESINOS CAPELO FRANCISCO;BERGEINFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS INTE;CASACOBOS GESTION SL;FUSTER TOME FELIPE. Presidente: BERGEMARITIMA SL. Vicepresid.: FUSTER TASA FELIPE ANDRES. VsecrNoConsj: MU脩OZ DE VERGER GARCIA ANTONIO.SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Con.Delegado: BERGE MARITIMA SL. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8, H A109357, I/A 3 (14.12.09).

23 de Diciembre de 2009
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 12潞.- Administraci贸n y Representaci贸n.. Datos registrales. T 3237 , F 31, S 8, H A 109357, I/A2 (14.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n