Buscador CIF Logo

Actos BORME Organizacion Gomez De Zamora Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Organizacion Gomez De Zamora Sl

Actos BORME Organizacion Gomez De Zamora Sl - B79849261

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Organizacion Gomez De Zamora Sl con CIF B79849261

馃敊 Perfil de Organizacion Gomez De Zamora Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Organizacion Gomez De Zamora Sl

10 de Octubre de 2022
Cambio de denominaci贸n social. OGOZA FASHION SL. Datos registrales. T 2136 , F 168, S 8, H M 37833, I/A 35 ( 3.10.22).

09 de Junio de 2022
Reelecciones. SecreNoConsj: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA REMEDIOS. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE.Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA. Cons.Del.Sol: GOMEZDE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Consejero: GARCIA GOMEZ DE ZAMORAMIGUEL ANGEL. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Datos registrales. T 2136 , F 167, S 8, H M 37833, I/A 34 (2.06.22).

15 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales.T 2136 , F 167, S 8, H M 37833, I/A 33 ( 5.11.21).

26 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales.T 2136 , F 167, S 8, H M 37833, I/A 32 (19.01.21).

21 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales.T 2136 , F 167, S 8, H M 37833, I/A 31 (14.11.19).

01 de Octubre de 2018
Reelecciones. Aud.C.Con.: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales.T 2136 , F 166, S 8, H M 37833, I/A 30 (24.09.18).

04 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales.T 2136 , F 166, S 8, H M 37833, I/A 29 (26.09.17).

04 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS.Secretario: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;GOMEZ DEZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Consejero: FORD PENELOPE ANN. Cons.Del.Sol: FORD PENELOPE ANN. Consejero: GARCIAMOLINA FRANCISCO. Cons.Del.Sol: GARCIA MOLINA FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA GOMEZ DEZAMORA REMEDIOS. Reelecciones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORAFORD CLEMENTE. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA FORDCAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Consejero: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL.Presidente: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN Y REFUNDEN LATOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de objeto social. LA ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACIONPOR CUALQUIER TITULO DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, SU SEGREGACION, DIVISION, AGRUPACION,VENTA, PARCELACION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION. LA ADQUISICION, TENENCIA Y ENAJENACION DE VALORESMOBILIARIOS... Datos registrales. T 2136 , F 163, S 8, H M 37833, I/A 28 (22.08.17).

29 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Nombramientos. Presidente: GOMEZ DEZAMORA FORD CLEMENTE. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 27陋 LA PUBLICACION DEL CESEDEL PRESIDENTE GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE Y EL NOMBRAMIENTO DE GOMEZ DE ZAMORA FORDCLEMENTE PARA EL MISMO CARGO. Datos registrales. T 2136 , F 162, S 8, H M 37833, I/A 27 (10.05.17).

19 de Mayo de 2017
Nombramientos. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE.Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DEZAMORA MIGUEL ANGEL. Consejero: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 2136 , F 162, S 8, H M37833, I/A 27 (10.05.17).

03 de Febrero de 2016
Cambio de domicilio social. C/ CANTABRIA, 2 - PRIMERA PLANTA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 2136 , F 162, S 8, H M37833, I/A 26 (27.01.16).

20 de Octubre de 2014
Nombramientos. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 2136 , F 162, S 8, H M 37833, I/A 25(10.10.14).

09 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BOMBIN ALONSO. Datos registrales. T 2136 , F 162, S 8, H M 37833, I/A 24 (2.04.13).

19 de Octubre de 2011
Nombramientos. Aud.C.Con.: HERNANDEZ Y ARRECUBIETA ESTUDIO DE AUDITORIA Y ECO. Reelecciones. Auditor:HERNANDEZ Y ARRECUBIETA ESTUDIO DE AUD.Y ECON. SL. Datos registrales. T 2136 , F 161, S 8, H M 37833, I/A 23 (6.10.11).

02 de Agosto de 2011
Ampliacion del objeto social. LA INTERMEDIACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTIONADMINISTRATIVA,. Datos registrales. T 2136 , F 161, S 8, H M 37833, I/A 22 (21.07.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n