Actos BORME de Orihuela Cultural Sl
19 de Julio de 2023Reelecciones. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Cambio de objeto social. La Sociedad tendrá por objeto laorganización y gestión de actividades culturales y turísticas. La Sociedad Pública Orihuela Cultural SL tiene, a efectos de lo dispuestoen el artículo 32 de la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídi.Datos registrales. T 4209 , F 98, S 8, H A 43203, I/A 29 (11.07.23).
17 de Julio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: LARRABIDE ACHUTEGUI AITOR LUIS;ZERON HUGUET. JESUS;BERNABE MARTINEZCARLOS;GOMEZ LORENTE FERNANDO PASCUAL;SALINAS BUENDIA JESUS;HERNANDEZ VALVERDE MARIAESTER;BASCUÑANA GALIANO EMILIO. Presidente: BASCUÑANA GALIANO EMILIO. Consejero: GRACIA GOMEZ CAROLINA.Revocaciones. Apoderado: RUIZ RODRIGUEZ LUIS;MARTINEZ VERACRUZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GOMEZLORENTE FERNANDO PASCUAL;SALINAS BUENDIA JESUS;GRACIA GIL MANUEL JAVIER;CAMPILLO SIMONMARTA;LARRABIDE ACHUTEGUI AITOR LUIS;ZERON HUGUET. JESUS;GRACIA GOMEZ CAROLINA. Presidente: GRACIAGOMEZ CAROLINA. Consejero: CANOVAS VERGEL GUILLERMO. Apoderado: MARTINEZ VERACRUZ FRANCISCO;RUIZRODRIGUEZ LUIS. Datos registrales. T 4209 , F 98, S 8, H A 43203, I/A 28 ( 6.07.23).
10 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Apoderado: SERRANO IVORRA NOELIA. Nombramientos. Apoderado: RUIZ RODRIGUEZ LUIS. Datosregistrales. T 4209 , F 98, S 8, H A 43203, I/A 27 ( 2.05.22).
09 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: LOPEZ-BAS VALERO JUAN IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: SERRANO IVORRA NOELIA.Datos registrales. T 4209 , F 97, S 8, H A 43203, I/A 26 ( 1.09.21).
23 de Agosto de 2021Nombramientos. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4209 , F 97, S 8, H A 43203, I/A 25(13.08.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ VERACRUZ FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-BAS VALERO JUANIGNACIO. Datos registrales. T 4209 , F 97, S 8, H A 43203, I/A 24 ( 9.06.21).
13 de Mayo de 2021Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ VALVERDE MARIA ESTER. Datos registrales. T 4209 , F 97, S 8, H A 43203, I/A 23 (5.05.21).
10 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: BASCUÑANA GALIANO EMILIO;GUTIERREZ MARCOS CARMEN MARIA;EZCURRA GARCIAMAR;BERNABE MARTINEZ CARLOS;GIMENEZ AVILA FRANCISCO;VALORIA MARTINEZ JULIA;VIDAL GUEVARA ANGELES.Presidente: BASCUÑANA GALIANO EMILIO. Consejero: ALMAGRO PALACIOS RAFAEL;CECILIA LOPEZ ASUNCION.Nombramientos. Consejero: BASCUÑANA GALIANO EMILIO;ALMAGRO PALACIOS RAFAEL;EZCURRA GARCIA MAR;BERNABEMARTINEZ CARLOS;GRACIA GOMEZ CAROLINA;GARCIA ESCOLANO JOSE MANUEL;ZERON HUGUET. JESUS;LARRABIDEACHUTEGUI AITOR LUIS. Presidente: BASCUÑANA GALIANO EMILIO. Datos registrales. T 4209 , F 96, S 8, H A 43203, I/A 22
12 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ IÑIGUEZ SOFIA;MONTIJANO EGEA CONCHA. Nombramientos. Consejero: ALMAGROPALACIOS RAFAEL;CECILIA LOPEZ ASUNCION. Datos registrales. T 4209 , F 96, S 8, H A 43203, I/A 21 ( 4.07.19).
13 de Mayo de 2019Nombramientos. Auditor: ABC AUDITORES MURCIANOS SLP. Datos registrales. T 4209 , F 96, S 8, H A 43203, I/A 20 ( 3.05.19).
03 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GUILLEN SAEZ MONSERRATE JESUS. Presidente: GUILLEN SAEZ MONSERRATE JESUS.Consejero: MAS DE SAN FELIX ANA JOSE;SMITH NICHOLAS;GARCIA LORCA EVA;RUIZ GIMENEZ JOSE;DIE MARINATANASIO;FERRANDO GARCIA JOSEFINA. SecreNoConsj: ESTREMERA SAURA JULIO VIRGILIO;RUBIO AMAYA MARIANIEVES. Consejero: CUARTERO ALONSO MARIA BEGOÑA. SecreNoConsj: DOMINGUEZ HERRERO FERNANDO. Revocaciones.Apoderado: SANCHEZ MATEOS MARIA CARMEN. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VERACRUZ FRANCISCO. Consejero:BASCUÑANA GALIANO EMILIO;CUARTERO ALONSO MARIA BEGOÑA;GUTIERREZ MARCOS CARMEN MARIA;EZCURRAGARCIA MAR;BERNABE MARTINEZ CARLOS;GIMENEZ AVILA FRANCISCO;VALORIA MARTINEZ JULIA;VIDAL GUEVARAANGELES;MONTIJANO EGEA CONCHA. Presidente: BASCUÑANA GALIANO EMILIO. SecreNoConsj: RUBIO AMAYA MARIANIEVES;DOMINGUEZ HERRERO FERNANDO. Consejero: ALVAREZ IÑIGUEZ SOFIA. SecreNoConsj: OFIGEM CONSULTORESSL. Modificaciones estatutarias. Artículo 12º. Facultades de la junta. Artículo 14º. Gestion y representación de la sociedad. Artículo3. Objeto social. Artículo 16º. Funcionamiento del consejo. Datos registrales. T 2023 , F 191, S 8, H A 43203, I/A 19 (17.04.19).
26 de Junio de 2015Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2023 , F 191, S 8, H A 43203, I/A 18 (18.06.15).
25 de Junio de 2015Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2023 , F 191, S 8, H A 43203, I/A 17 (17.06.15).
21 de Enero de 2015Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2023 , F 191, S 8, H A 43203, I/A 16 (13.01.15).
20 de Enero de 2015Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2023 , F 191, S 8, H A 43203, I/A 15 (13.01.15).
25 de Junio de 2014Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2023 , F 191, S 8, H A 43203, I/A 14 (16.06.14).
08 de Enero de 2014Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2023 , F 191, S 8, H A 43203, I/A 13 (27.12.13).
24 de Octubre de 2013Fe de erratas: La fecha de nombramiento del sujeto nombrado que consta en la inscripción 12&, es 4 de mayo de 2012. Datosregistrales. T 2023 , F 190, S 8, H A 43203, I/A 12 (23.07.12).
02 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: LOPEZ GOMEZ ARTURO JOSE. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MATEOS MARIA CARMEN.Datos registrales. T 2023 , F 190, S 8, H A 43203, I/A 12 (23.07.12).
30 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ESTREMERA SAURA JULIO VIRGILIO. Consejero: LORENTE RAMON MONICA;FERRANDOGARCIA JOSEFINA;MAS DE SAN FELIX ANA JOSE;VEGARA DURA JOSE;ZARAGOZA FAURA JUAN MANUEL;SERRANO ROMANMARIA JOSE;GALIANA FERRER ALEJANDRO. Presidente: LORENTE RAMON MONICA. Nombramientos. SecreNoConsj:ESTREMERA SAURA JULIO VIRGILIO. Consejero: GUILLEN SAEZ MONSERRATE JESUS. Presidente: GUILLEN SAEZMONSERRATE JESUS. Consejero: MAS DE SAN FELIX ANA JOSE;SMITH NICHOLAS;GARCIA LORCA EVA;RUIZ GIMENEZJOSE;DIE MARIN ATANASIO;FERRANDO GARCIA JOSEFINA. Datos registrales. T 2023 , F 190, S 8, H A 43203, I/A 11 (18.07.12).
14 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ FRANCO ALFONSO RAMON. Nombramientos. SecreNoConsj: ESTREMERASAURA JULIO VIRGILIO. Datos registrales. T 2023 , F 190, S 8, H A 43203, I/A 10 ( 4.07.11).
31 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ FRANCO ALFONSO RAMON. Consejero: HERNANDEZ TERRES MANUEL;LUCASTOMAS ENRIQUE;ZAPLANA POLO EMILIO;MEDINA CAÑIZARES JOSE MANUEL;GARCIA ORTUÑO AGUSTIN;FERRANDEZ RUIZENCARNACION;LOPEZ EGIO EDUARDOPresidente: MEDINA CAÑIZARES JOSE MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj:MARTINEZ FRANCO ALFONSO RAMON. Consejero: LORENTE RAMON MONICA;FERRANDO GARCIA JOSEFINA;MAS DE SANFELIX ANA JOSE;VEGARA DURA JOSE;ZARAGOZA FAURA JUAN MANUEL;SERRANO ROMAN MARIA JOSE;GALIANA FERRERALEJANDRO. Presidente: LORENTE RAMON MONICA. Datos registrales. T 2023 , F 190, S 8, H A 43203, I/A 9 (19.08.09).