Buscador CIF Logo

Actos BORME Ormats Mantenimiento Integral Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ormats Mantenimiento Integral Sl

Actos BORME Ormats Mantenimiento Integral Sl - B14921621

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ormats Mantenimiento Integral Sl con CIF B14921621

馃敊 Perfil de Ormats Mantenimiento Integral Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ormats Mantenimiento Integral Sl

01 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: OLAGUIBEL AMICH I脩IGO;PEREZ MARCOS OSCAR;ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANOPABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL;VALENCIA MU脩OZ PABLO;OLACIREGUI DAGUE MATEO;RUMI PALOMO ROSA.Nombramientos. Apoderado: VALENCIANO VILLAFAINA ALFREDO. Cambio de domicilio social. C/ PRINCESA 24, 2潞IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 40713 , F 133, S 8, H M 722454, I/A 6 (22.02.23).

29 de Septiembre de 2021
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZOFRA DIRECTORSHIP SL. Nombramientos.Consejero: VALENCIANO VILLAFAINA ALFREDO;SANCHEZ GARCIA ENRIQUE;ZOFRA DIRECTORSHIP SL. Presidente: SANCHEZGARCIA ENRIQUE. Secretario: ZOFRA DIRECTORSHIP SL. Con.Delegado: SANCHEZ GARCIA ENRIQUE. Representan:FERNANDEZ HERNANSAIZ JOSE RAMON. Modificaciones estatutarias. Se aprueba un texto refundido de estatutos sociales..Otros conceptos: CESA VICENTE ASUERO RESUSTA COMO REPRESENTANTE FISICO DEL ADMINISTRADOR UNICOCESADO. Datos registrales. T 40713 , F 129, S 8, H M 722454, I/A 5 (22.09.21).

28 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: OLACIREGUI DAGUE MATEO;RUMI PALOMO ROSA. Datos registrales. T 40713 , F 128, S 8, H M722454, I/A 4 (21.10.20).

23 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: VIZCAINO GARCIA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 40713 , F 128, S 8, H M 722454, I/A 3(16.09.20).

03 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: OLAGUIBEL AMICH I脩IGO;PEREZ MARCOS OSCAR;ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZSORIANO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL;VALENCIA MU脩OZ PABLO. Cambio de domicilio social. C/ JENNER - NUMERO 3,4潞C (MADRID). Datos registrales. T 40713 , F 125, S 8, H M 722454, I/A 2 (26.08.20).

12 de Agosto de 2020
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ZOFRA DIRECTORSHIP SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MAGDALENOISIDRO. Presidente: LOPEZ MAGDALENO ISIDRO. Consejero: ARCE ALONSO RAUL. Cons.Del.Man: ARCE ALONSO RAUL.Consejero: CUESTA LARRE ANDRES. Cons.Del.Man: CUESTA LARRE ANDRES. SecreNoConsj: MARIN FERNANDEZ VICENTE.Nombramientos. Adm. Unico: ZOFRA DIRECTORSHIP SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2237 , F 138, S 8, H CO 31175, I/A 7 ( 3.08.20).

10 de Agosto de 2016
Reelecciones. Consejero: LOPEZ MAGDALENO ISIDRO. Presidente: LOPEZ MAGDALENO ISIDRO. Consejero: ARCE ALONSORAUL. Cons.Del.Man: ARCE ALONSO RAUL. Consejero: CUESTA LARRE ANDRES. Cons.Del.Man: CUESTA LARRE ANDRES.SecreNoConsj: MARIN FERNANDEZ VICENTE. Datos registrales. T 2237 , F 138, S 8, H CO 31175, I/A 6 ( 4.08.16).

11 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DOMINGUEZ SIDERA JUA LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: MARIN FERNANDEZVICENTE. Datos registrales. T 2237 , F 137, S 8, H CO 31175, I/A 5 ( 4.06.14).

03 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Man: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: CUESTA LARRE ANDRES. Cons.Del.Man: CUESTA LARRE ANDRES. Datos registrales. T 2237 , F137, S 8, H CO 31175, I/A 4 (26.09.13).

22 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: VIZCAINO GARCIA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 2237 , F 136, S 8, H CO 31175, I/A 3(14.11.12).

30 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARPINTERO GRANDE JAVIER. Cons.Del.Man: CARPINTERO GRANDE JAVIER.Nombramientos. Consejero: ARCE ALONSO RAUL. Cons.Del.Man: ARCE ALONSO RAUL. Datos registrales. T 2237 , F 136, S 8,H CO 31175, I/A 2 (22.08.12).

01 de Agosto de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.05.11. Objeto social: La realizaci贸n de servicios de mantenimiento general eninfraestructuras yel mantenimiento de l铆neas y servicios generales en instalaciones industriales. Servicio integral de cualquier tipomantenimiento de edificios, navesy renovables. Dise帽o, legalizaci贸n y construcci贸n de peque帽as renovaciones,. Domicilio: C/GABRIEL RAMOS BEJARANO 114 - POLIGONO DE LAS QU (CORDOBA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero:LOPEZ MAGDALENO ISIDRO. Presidente: LOPEZ MAGDALENO ISIDRO. Consejero: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER.Cons.Del.Man: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Consejero: CARPINTERO GRANDE JAVIER. Cons.Del.Man: CARPINTEROGRANDE JAVIER. SecreNoConsj: DOMINGUEZ SIDERA JUA LUIS. Datos registrales. T 2237 , F 131, S 8, H CO 31175, I/A 1(20.07.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n