Buscador CIF Logo

Actos BORME Orovalle Minerals Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Orovalle Minerals Sl

Actos BORME Orovalle Minerals Sl - B84963537

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Orovalle Minerals Sl con CIF B84963537

🔙 Perfil de Orovalle Minerals Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Orovalle Minerals Sl

08 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 39, S 8, H AS 40244, I/A62 ( 1.08.22).

30 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: MENENDEZ MARTINEZ NURIA;HERNANDO GAVIDIA JUAN;DUC VU BINH;GARCIA SANCHEZMARIA;MANGA FERANNDEZ TATIANA MACARENA. Apo.Sol.: MENENDEZ MARTINEZ NURIA;OREJAS MARTINEZCRISTINA;ALVAREZ DE ARRIBA MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: HERNANDO GAVIDIA JUAN;DUC VU BINH;MENENDEZMARTINEZ NURIA;GARCIA SANCHEZ MARIA;COLLAR GARCIA RUBEN;MANGA FERNANDEZ TATITANA MACARENA;OREJASMARTINEZ CRISTINA;SOLER MONRABAL JORGE;GARRIDO CUESTA PATRICIA. Apo.Sol.: MENENDEZ MARTINEZNURIA;OREJAS MARTINEZ CRISTINA;SOLER MONRABAL JORGE;GARRIDO CUESTA PATRICIA. Datos registrales. T 4122 , F26, S 8, H AS 40244, I/A 61 (20.09.21).

16 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 26, S 8, H AS 40244, I/A60 ( 6.08.21).

22 de Julio de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 26, S 8, H AS 40244, I/A59 (14.07.20).

06 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Secretario: COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Revocaciones.Apo.Manc.: COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Apo.Sol.: COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Nombramientos. Secretario: MENENDEZMARTINEZ NURIA. Datos registrales. T 4122 , F 25, S 8, H AS 40244, I/A 58 (23.04.20).

16 de Julio de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: ARGUELLES FERNANDEZ CARMEN. Apo.Sol.: COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Apo.Manc.: COBOSSAMPEDRO GABRIEL;GARCIA SANCHEZ MARIA;HILLIS JEFFREY ANDREW;MENENDEZ MARTINEZ NURIA. Apo.Sol.:MENENDEZ MARTINEZ NURIA. Apo.Manc.: HERNANDO GAVIDIA JUAN. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANEZ ISABEL;FERNANDEZFERNANDEZ CESAR ADOLFO. Apo.Manc.: MANGA FERNANDEZ TATITANA MACARENA. Nombramientos. Apo.Manc.:MENENDEZ MARTINEZ NURIA;HERNANDO GAVIDIA JUAN;COBOS SAMPEDRO GABRIEL;DUC VU BINH;GARCIA SANCHEZMARIA;MANGA FERANNDEZ TATIANA MACARENA. Apo.Sol.: MENENDEZ MARTINEZ NURIA;COBOS SAMPEDROGABRIEL;OREJAS MARTINEZ CRISTINA;ALVAREZ DE ARRIBA MARIA. Datos registrales. T 4122 , F 23, S 8, H AS 40244, I/A 57 (9.07.19).

13 de Junio de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 23, S 8, H AS 40244, I/A56 ( 5.06.19).

19 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: DUNCAN DAVID MICHAEL. Datos registrales. T 4122 , F 22, S 8, H AS 40244, I/A 55 ( 7.02.19).

30 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DUNCAN DAVID MICHAEL. Nombramientos. Consejero: DUC VU BINH. Datos registrales. T4122 , F 22, S 8, H AS 40244, I/A 54 (21.01.19).

05 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 22, S 8, H AS 40244, I/A53 (26.10.18).

03 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ COUTADO DAVID. Nombramientos. Apo.Manc.: MANGA FERNANDEZ TATITANAMACARENA. Datos registrales. T 4122 , F 22, S 8, H AS 40244, I/A 52 (23.04.18).

10 de Octubre de 2017
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Capital: 11.938.575,00 Euros. Resultante Suscrito: 15.718.500,00Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 4122 , F 21, S 8, H AS 40244,I/A 51 (29.09.17).

07 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 21, S 8, H AS 40244, I/A50 (27.07.17).

17 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: MUÑOZ PAREDES JOSE MARIA. Vicesecret.: RAMIREZ PAYER CONCEPCION. Consejero: HILLISJEFFREY ANDREW;ALVAREZ RUEDA JUAN JOSE. Presidente: HILLIS JEFFREY ANDREW. Vicepresid.: HERNANDO GAVIDIAJUAN. Revocaciones. Apo.Manc.: HILLIS JEFFREY ANDREW;MENENDEZ MARTINEZ NURIA;ARGUELLES FERNANDEZCARMEN;COBOS SAMPEDRO GABRIEL;CHAN JEFF;FERNANDEZ COUTADO DAVID;GARCIA SANCHEZ MARIA. Apo.Sol.:GAITAN CASTILLO JOSE LUIS;FERNANDEZ FERNANEZ ISABEL;COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Nombramientos. Consejero:MENENDEZ MARTINEZ NURIA;COBOS SAMPEDRO GABRIEL;DUNCAN DAVID MICHAEL. Presidente: HERNANDO GAVIDIAJUAN. Secretario: COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Apo.Manc.: HILLIS JEFFREY ANDREW;DUNCAN DAVID MICHAEL;HERNANDOGAVIDIA JUAN;COBOS SAMPEDRO GABRIEL;MENENDEZ MARTINEZ NURIA;GARCIA SANCHEZ MARIA;ARGUELLESFERNANDEZ CARMEN;FERNANDEZ COUTADO DAVID. Apo.Sol.: MENENDEZ MARTINEZ NURIA;COBOS SAMPEDROGABRIEL;FERNANDEZ FERNANEZ ISABEL;FERNANDEZ FERNANDEZ CESAR ADOLFO. Datos registrales. T 4122 , F 19, S 8, HAS 40244, I/A 49 ( 8.03.17).

21 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 19, S 8, H AS 40244, I/A48 (13.10.16).

22 de Agosto de 2016
Modificaciones estatutarias. 12. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 4122 , F 19, S 8, H AS 40244, I/A 47 (11.08.16).

20 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIMITROV DANIELLA;NUNES JOAO LUIS MATEUS. Presidente: DIMITROV DANIELLA. Vicepresid.:NUNES JOAO LUIS MATEUS. Revocaciones. Apo.Manc.: DIMITROV DANIELLA;NUNES JOAO LUIS MATEUS;RUI OLIVEIRA DASILVA MARIO;MARINO CHRISTINE. Nombramientos. Consejero: ALVAREZ RUEDA JUAN JOSE;HERNANDO GAVIDIA JUAN.Presidente: HILLIS JEFFREY ANDREW. Vicepresid.: HERNANDO GAVIDIA JUAN. Datos registrales. T 4122 , F 18, S 8, H AS40244, I/A 46 (12.04.16).

22 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: DIMITROV DANIELLA;WINSHIP MICHAEL DAVID;NUNES JOAO LUIS MATEUS;RINGDAHL NEILTORBEN;MARINO CHRISTINE;ARGUELLES FERNANDEZ CARMEN;CHAN JEFF. Apo.Sol.: GAITAN CASTILLO JOSE LUIS.Apo.Manc.: MENENDEZ MARTINEZ NURIA;WINSHIP MICHAEL DAVID;DIMITROV DANIELLA;RODRIGUEZ PEREZ JORGE;NUNESJOAO LUIS MATEUS;RINGDAHL NEIL TORBEN;FERNANDEZ COUTADO DAVID;WINSHIP MICHAEL DAVID;DIMITROVDANIELLA;MENENDEZ MARTINEZ NURIA;NUNES JOAO LUIS MATEUS;RINGDAHL NEIL TORBEN;MENENDEZ MARTINEZNURIA;DIMITROV DANIELLA;WINSHIP MICHAEL DAVID;NUNES JOAO LUIS MATEUS;RINGDAHL NEIL TORBEN;MENENDEZMARTINEZ NURIA;FERNANDEZ COUTADO DAVID;ARGUELLES FERNANDEZ CARMEN;MARINO CHRISTINE;CHANJEFF;WINSHIP MICHAEL DAVID;DIMITROV DANIELLA;NUNES JOAO LUIS MATEUS;RINGDAHL NEIL TORBEN. Nombramientos.Apo.Manc.: DIMITROV DANIELLA;NUNES JOAO LUIS MATEUS;HILLIS JEFFREY ANDREW;RUI OLIVEIRA DA SILVAMARIO;MENENDEZ MARTINEZ NURIA;ARGUELLES FERNANDEZ CARMEN;COBOS SAMPEDRO GABRIEL;MARINOCHRISTINE;CHAN JEFF;FERNANDEZ COUTADO DAVID;GARCIA SANCHEZ MARIA. Apo.Sol.: GAITAN CASTILLO JOSELUIS;FERNANDEZ FERNANEZ ISABEL;COBOS SAMPEDRO GABRIEL. Datos registrales. T 4122 , F 14, S 8, H AS 40244, I/A 45(11.02.16).

19 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 14, S 8, H AS 40244, I/A43 ( 7.10.15).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4122 , F 14, S 8, H AS 40244, I/A44 ( 7.10.15).

10 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: WINSHIP MICHAEL D. Presidente: WINSHIP MICHAEL D. Vicepresid.: DIMITROV DANIELLA.Nombramientos. Consejero: HILLIS JEFFREY ANDREW. Presidente: DIMITROV DANIELLA. Vicepresid.: NUNES JOAO LUISMATEUS. Datos registrales. T 4122 , F 14, S 8, H AS 40244, I/A 42 (31.07.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información