Actos BORME de Ortho-clinical Diagnostics Spain Sl
29 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31955 , F 217, S 8, H M 575105, I/A 33 (22.11.23).
17 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: COCIRTA DOINA. Datos registrales. T 31955 , F 216, S 8, H M 575105, I/A 32 (10.09.21).
10 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: RSM SPAINAUDITORES SLP. Aud.C.Con.: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31955 , F 216, S 8, H M 575105, I/A 31(30.10.20).
13 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: SALAMANCA CUEVAS LORENA;DIAZ HERNANDEZ AMPARO;MERINO JIMENEZ NATALIA;LLADOOBRADOR ANTONIA MARIA;DE DIEGO VARGAS EUGENIA. Apoderado: SILVA CORREIA ANTONIO PAULO. Apo.Sol.:HAUTEQUEST RUDI LOUIS CLEMENT;MORALES DE COCA MARIA DEL CARMEN;BERROCAL MUELA ANGEL;RODRIGUEZLOPEZ MANUEL;DE-LA-SERNA DONO LUIS;CASTELLANO CASAS IGNACIO;PARADA GUTIERREZ MARIA-DOLORES;DOMINGUEZ CALLE ANA;RODRIGUEZ ARRIETA ARANZAZU;SUAREZ CASTELO ODON. Apoderado: DEL MONTEVICENTE ANA. Datos registrales. T 31955 , F 215, S 8, H M 575105, I/A 30 ( 6.08.20).
11 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BONAITA RENATO. Datos registrales. T 31955 , F 215, S 8, H M 575105, I/A 29 ( 4.08.20).
10 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: BRITTO LEON LEONARDO. Datos registrales. T 31955 , F 215, S 8, H M 575105, I/A 28 (27.12.19).
19 de Diciembre de 2019Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio social . Cambio de domicilio social. VIA DE LOS POBLADOS1-3 3陋 - POLIGONO EMPRESARIAL (MADRID). Datos registrales. T 31955 , F 214, S 8, H M 575105, I/A 27 (12.12.19).
04 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: BACOVA MARKETA. Datos registrales. T 31955 , F 214, S 8, H M 575105, I/A 26 (27.09.19).
02 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BONAITA RENATO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 24陋 la publicacion del cesedel administrador 煤nico BONAITA RENATO. Datos registrales. T 31955 , F 211, S 8, H M 575105, I/A 24 ( 5.08.19).
20 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: BARRIOS MARTINEZ DAVID. Datos registrales. T 31955 , F 212, S 8, H M 575105, I/A 25 (12.08.19).
12 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SOCARRAS ALEXANDER ANTONIO;BONAITA RENATO. Nombramientos. Adm. Unico:BONAITA RENATO. Consejero: BONAITA RENATO;MARTIN DUAIGUES JOAN;BARRIOS MARTINEZ DAVID. Secretario: BARRIOSMARTINEZ DAVID. Presidente: MARTIN DUAIGUES JOAN. Consejero: READ DEAN ANDREW. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 31955 , F 211, S 8, H M 575105, I/A 24 ( 5.08.19).
09 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: DEL MONTE VICENTE ANA. Datos registrales. T 31955 , F 211, S 8, H M 575105, I/A 23 ( 2.04.19).
21 de Enero de 2019Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31955 , F 210, S 8, H M575105, I/A 22 (14.01.19).
26 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SILVA CORREIA ANTONIO PAULO. Nombramientos. Adm. Solid.: BONAITA RENATO. Datosregistrales. T 31955 , F 210, S 8, H M 575105, I/A 21 (16.11.18).
20 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: LEDUR FREDERIC. Datos registrales. T 31955 , F 210, S 8, H M 575105, I/A 20 ( 1.03.18).
06 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31955 , F 210, S 8, H M 575105,I/A 19 (27.02.18).
16 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: PRIOLO MARIA;PRADA CAMACHO MARIA ANGELES. Datos registrales. T 31955 , F 209, S 8, H M575105, I/A 18 ( 5.05.17).
29 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: BERROCAL MUELA ANGEL;RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL;DE-LA-SERNA DONO LUIS;CASTELLANOCASAS IGNACIO;PARADA GUTIERREZ MARIA-DOLORES;DOMINGUEZ CALLE ANA;RODRIGUEZ ARRIETA ARANZAZU;SUAREZCASTELO ODON. Datos registrales. T 31955 , F 209, S 8, H M 575105, I/A 17 (18.03.16).
12 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: VARGAS SEVA FERNANDO. Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES DE COCA MARIA DEL CARMEN.Datos registrales. T 31955 , F 208, S 8, H M 575105, I/A 16 ( 4.02.16).
03 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: SANDERS JOHN-KENNETH;FRANK JOSEPH-H;DAVIS ELISABETTA. Nombramientos. Apoderado:SANDERS JOHN-KENNETH;CAMPBELL MICHAEL-GERARD;DAVIS ELISABETTA. Datos registrales. T 31955 , F 207, S 8, H M575105, I/A 15 (26.10.15).
28 de Abril de 2015Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31955 , F 207, S 8, H M 575105,I/A 14 (20.04.15).
02 de Febrero de 2015Cambio de domicilio social. AVDA DEL PARTENON 10 -3 (MADRID). Datos registrales. T 31955 , F 205, S 8, H M 575105, I/A 12(23.01.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: HAUTEQUEST RUDI LOUIS CLEMENT;SOTO MARTINEZ PIQUERAS SONSOLES;VARGAS SEVAFERNANDO. Datos registrales. T 31955 , F 206, S 8, H M 575105, I/A 13 (23.01.15).
17 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SILVA CORREIA ANTONIO PAULO. Nombramientos. Adm. Solid.: SILVA CORREIA ANTONIOPAULO;SOCARRAS ALEXANDER ANTONIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 31955 , F 205, S 8, H M 575105, I/A 11 ( 9.09.14).
28 de Agosto de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 2,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.002,00 Euros. Datos registrales. T 31955 , F 8, S 8, H M 575105,I/A 10 (20.08.14).
06 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JAGANNATH RAM MOHAN;SCHMIDT ROBER-ROLAND. Nombramientos. Adm. Unico: SILVACORREIA ANTONIO PAULO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Cambio de domicilio social. PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 5-7 - CAMPO DE LAS NAC (MADRID). Datos registrales.T 31955 , F 8, S 8, H M 575105, I/A 9 (28.07.14).
25 de Julio de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS NETHERLANDS BV. Datosregistrales. T 31955 , F 6, S 8, H M 575105, I/A 7 (18.07.14).
Nombramientos. Apoderado: SILVA CORREIA ANTONIO PAULO. Datos registrales. T 31955 , F 6, S 8, H M 575105, I/A 8(18.07.14).
30 de Mayo de 2014Otros conceptos: CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO, " Ortho-clinical Diagnostics Bermuda Co.Ltd ".- Cambio deobjeto social. CNAE-4646.-El objeto social de la Sociedad consistir谩 en lafabricaci贸n, distribuci贸n, comercializaci贸n y venta deproductos de productos sanitarios, farmac茅uticos, destinados al cuidado de la salud y de diagn贸stico in-vitroy la provisi贸n de todo tipode servicios relacionados con los mismos,. Datos registrales. T 31955 , F 5, S 8, H M 575105, I/A 6 (22.05.14).
28 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: SANDERS JOHN-KENNETH;FRANK JOSEPH-H;DAVIS ELISABETTA. Datos registrales. T 31955 , F5, S 8, H M 575105, I/A 5 (20.05.14).