Actos BORME de Osga Sl
18 de Octubre de 2023Revocaciones. Apoderado: TEJADA HERREROS MARIA FELISA. Datos registrales. T 873 , F 211, S 8, H LO 5739, I/A 66 (9.10.23).
Revocaciones. Apoderado: SAINZ GARCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 873 , F 211, S 8, H LO 5739, I/A 67 ( 9.10.23).
07 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: TAURONI BURGOS DAVID. Datos registrales. T 861 , F 61, S 8, H LO 5739, I/A 64 (28.07.23).
Nombramientos. Apoderado: SERRANO GOMEZ SONIA. Datos registrales. T 861 , F 61, S 8, H LO 5739, I/A 65 (28.07.23).
27 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: LAGUNA PEDRAZA JUAN JOSE;GARCES AZOFRA ALFONSO;GARRES VELASCOVIRGINIA;GARCES AZOFRA ALFONSO;GARRES VELASCO VIRGINIA. Datos registrales. T 861 , F 60, S 8, H LO 5739, I/A 62(16.03.23).
Nombramientos. Apoderado: GARRES VELASCO VIRGINIA. Datos registrales. T 861 , F 61, S 8, H LO 5739, I/A 63 (16.03.23).
13 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: TOLEDO SANTANA ESTHER LIDIA. Datos registrales. T 861 , F 60, S 8, H LO 5739, I/A 60 ( 1.02.23).
Revocaciones. Apoderado: LARREA DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 861 , F 60, S 8, H LO 5739, I/A 61 (1.02.23).
27 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO TOMAS. Datos registrales. T 861 , F 59, S 8, H LO 5739, I/A59 (15.12.22).
18 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: GARRO ORTU脩O ADRIANA;RUIZ MIGUEL SALVADOR;GUERRERO FRECHILLA GONZALO. Datosregistrales. T 861 , F 59, S 8, H LO 5739, I/A 58 ( 4.04.22).
04 de Abril de 2022Nombramientos. Auditor: AUDIPYMES AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 861 , F 59, S 8, HLO 5739, I/A 57 (23.03.22).
02 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ FONSECA JOAQUIN GONZALO. Datos registrales. T 861 , F 59, S 8, H LO 5739, I/A 56(23.02.22).
16 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALILEA CID OSCAR. Nombramientos. Adm. Unico: OSGA REINTEGRA SL. Cambio de objetosocial. La integraci贸n laboral y social, asistencia y servicios sociales, para personas en situaci贸n de discapacidad, ya sea f铆sica,ps铆quica y/o sensorial, con la finalidad de asegurar un empleo remunerado y digno, as铆 como la realizaci贸n de un ajuste de personal ysocial, mediante la realizaci贸n de un aju. Datos registrales. T 861 , F 58, S 8, H LO 5739, I/A 55 (24.11.21).
12 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: SORIA CATALU脩A MONICA. Datos registrales. T 861 , F 58, S 8, H LO 5739, I/A 54 ( 3.11.21).
15 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ FONSECA JOAQUIN GONZALO. Datos registrales. T 861 , F 57, S 8, H LO 5739, I/A53 ( 1.07.21).
02 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: SAINZ GARCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 861 , F 55, S 8, H LO 5739, I/A 49 (21.06.21).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 861 , F 56, S 8, H LO 5739, I/A 50(21.06.21).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ-MONCAYO ASENJO MARIANO. Datos registrales. T 861 , F 56, S 8, H LO 5739, I/A 51(21.06.21).
Nombramientos. Apoderado: BURGOS GIL SUSANA. Datos registrales. T 861 , F 57, S 8, H LO 5739, I/A 52 (22.06.21).
22 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: TOLEDO SANTANA ESTHER LIDIA. Datos registrales. T 861 , F 55, S 8, H LO 5739, I/A 48 ( 7.06.21).
02 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ MATEOS EVARISTO. Datos registrales. T 861 , F 55, S 8, H LO 5739, I/A 46 (21.01.21).
Revocaciones. Apoderado: FELEZ IBORTE LUIS JOAQUIN. Datos registrales. T 861 , F 55, S 8, H LO 5739, I/A 47 (21.01.21).
10 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: LAGUNA PEDRAZA JUAN JOSE. Datos registrales. T 840 , F 39, S 8, H LO 5739, I/A 45 ( 3.03.20).
20 de Febrero de 2020Cambio de domicilio social. C/ CORDONERA 2 - POLIGONO INDUSTRIAL LA PORTALADA (LOGRO脩O). Cambio de objetosocial. La sociedad tendr谩 por objeto la integraci贸n laboral y social, asistencia y servicios sociales, para personas en situaci贸n dediscapacidad, ya sea f铆sica, ps铆quica y/o sensorial, con la finalidad de asegurar un empleo remunerado y digno, as铆 como la realizaci贸nde un ajuste personal y social, media. Datos registrales. T 840 , F 38, S 8, H LO 5739, I/A 44 (11.02.20).
11 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: AUDIPYMES AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 840 , F 38, S 8, HLO 5739, I/A 43 (29.11.19).
27 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ SERRANO FRANCISCO. Datos registrales. T 840 , F 38, S 8, H LO 5739, I/A 42 (20.09.19).
22 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: GUERRERO FRECHILLA GONZALO. Datos registrales. T 840 , F 37, S 8, H LO 5739, I/A 40(12.07.19).
Nombramientos. Apoderado: FELEZ IBORTE LUIS JOAQUIN. Datos registrales. T 840 , F 38, S 8, H LO 5739, I/A 41 (12.07.19).
11 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: RUIZ MIGUEL SALVADOR. Datos registrales. T 840 , F 37, S 8, H LO 5739, I/A 39 ( 3.07.19).
07 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: ANGULO RODRIGO FERNANDO. Datos registrales. T 840 , F 36, S 8, H LO 5739, I/A 37 (30.01.19).
Revocaciones. Apoderado: CA脩AS VILLEDIEU CARLOS. Datos registrales. T 840 , F 36, S 8, H LO 5739, I/A 38 (30.01.19).
28 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO TOMAS. Datos registrales. T 840 , F 35, S 8, H LO 5739,I/A 34 (19.12.18).
Revocaciones. Apoderado: SORIA CATALU脩A MONICA. Datos registrales. T 840 , F 36, S 8, H LO 5739, I/A 35 (19.12.18).
Nombramientos. Apoderado: LARREA DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 840 , F 36, S 8, H LO 5739, I/A 36(19.12.18).
02 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: ESTEVENS DASI GEMMA. Datos registrales. T 721 , F 197, S 8, H LO 5739, I/A 29 (22.06.18).
Nombramientos. Apoderado: TOLEDO SANTANA ESTHER LIDIA. Datos registrales. T 840 , F 34, S 8, H LO 5739, I/A 31(22.06.18).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TOLEDO SANTANA ESTHER LIDIA. Nombramientos. Adm. Unico: GALILEA CID OSCAR. Datosregistrales. T 840 , F 34, S 8, H LO 5739, I/A 30 (22.06.18).
Nombramientos. Apoderado: SORIA CATALU脩A MONICA;SORIA CATALU脩A MONICA. Datos registrales. T 840 , F 35, S 8, H LO5739, I/A 33 (22.06.18).
05 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: SEBASTIAN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 721 , F 197, S 8, H LO 5739, I/A 27(22.02.18).
Nombramientos. Apoderado: GARRO ORTU脩O ADRIANA. Datos registrales. T 721 , F 197, S 8, H LO 5739, I/A 28 (23.02.18).
19 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ MATEOS EVARISTO;ESTEVENS DASI GEMMA. Datos registrales. T 721 , F 197, S 8, HLO 5739, I/A 26 ( 9.01.18).
05 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ SERRANO FRANCISCO. Datos registrales. T 721 , F 196, S 8, H LO 5739, I/A 24(26.12.17).
Nombramientos. Apoderado: CA脩AS VILLEDIEU CARLOS. Datos registrales. T 721 , F 196, S 8, H LO 5739, I/A 25 (26.12.17).
14 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: ANGULO RODRIGO FERNANDO. Datos registrales. T 721 , F 195, S 8, H LO 5739, I/A 21 ( 5.09.17).
Nombramientos. Apoderado: SEBASTIAN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 721 , F 195, S 8, H LO 5739, I/A22 ( 5.09.17).
Nombramientos. Apoderado: TEJADA HERREROS MARIA FELISA. Datos registrales. T 721 , F 195, S 8, H LO 5739, I/A 23 (5.09.17).
25 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: RAMON HERNANDEZ BEATRIZ;DAVILA DAVILA MARCO. Datos registrales. T 721 , F 194, S 8, H LO5739, I/A 19 (18.07.17).
Revocaciones. Apoderado: CORDOBA ARPON LAURA. Datos registrales. T 721 , F 195, S 8, H LO 5739, I/A 20 (18.07.17).
09 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALILEA CID OSCAR. Nombramientos. Adm. Unico: TOLEDO SANTANA ESTHER LIDIA. Datosregistrales. T 721 , F 193, S 8, H LO 5739, I/A 17 (29.04.16).
Nombramientos. Apoderado: GALILEA CID OSCAR. Datos registrales. T 721 , F 194, S 8, H LO 5739, I/A 18 (29.04.16).
01 de Abril de 2016Ampliacion del objeto social. Transporte de mercanc铆as por carretera. Servicios de mudanzas. Servicio de carga y descarga yalmacenamiento. Servicio de almacenaje y control. Servicio de mensajer铆a. Servicio de reparaci贸n y mantenimiento de bombas,v谩lvulas, grifos contenedores, contenedores met谩licos. Servicio de reparaci贸n y. Datos registrales. T 721 , F 193, S 8, H LO 5739, I/A16 (23.03.16).
16 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 34.000,96 Euros. Resultante Suscrito: 37.010,96 Euros. Datos registrales. T 423 , F 40, S 8, H LO5739, I/A 15 ( 4.12.15).
08 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: TOLEDO SANTANA ESTHER LIDIA. Datos registrales. T 423 , F 40, S 8, H LO 5739, I/A 14(25.09.15).
04 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: CORDOBA ARPON LAURA. Datos registrales. T 423 , F 39, S 8, H LO 5739, I/A 12 (25.08.15).
Nombramientos. Apoderado: DAVILA DAVILA MARCO. Datos registrales. T 423 , F 39, S 8, H LO 5739, I/A 13 (25.08.15).
10 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: RAMON HERNANDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 423 , F 39, S 8, H LO 5739, I/A 11 ( 2.12.14).
30 de Junio de 2014Ampliacion del objeto social. Comercio al por menor y al por mayor de art铆culos de menaje, ferreter铆a, herramientas, adorno, regalo,reclamo, bisuter铆a y peque帽os electrodom茅sticos. Comercio al por menor de prendas especiales y equipos de protecci贸n individual(EPI). Servicios de envasado, almacenaje, manipulaci贸n y embalaje d. Datos registrales. T 423 , F 38, S 8, H LO 5739, I/A 10(23.06.14).
03 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: CORDOBA ARPON LAURA. Datos registrales. T 423 , F 38, S 8, H LO 5739, I/A 9 (24.02.14).
06 de Junio de 2012Ampliacion del objeto social. - Toma de medidas y lecturas de diversos aparatos: contadores de agua, luz, gas, otros medidoresindustriales. - Gesti贸n de n贸minas, seguros, contabilidad y an谩logos para terceros. Tareas de asesor铆a laboral, comercial, industrial, ode calidad. - Reparaci贸n y mantenimiento preventivo correctivo y/o. Datos registrales. T 423 , F 37, S 8, H LO 5739, I/A 8 (28.05.12).
14 de Enero de 2010Cambio de domicilio social. C/ LABRADORES 23 BAJO (LOGRO脩O). Datos registrales. T 423 , F 37, S 8, H LO 5739, I/A 6 (4.01.10).
Cambio de domicilio social. C/ PORTALADA 50 - NAVE G-4, POLIGONO INDUSTIRAL LA (LOGRO脩O). Datos registrales. T 423, F 37, S 8, H LO 5739, I/A 7 ( 4.01.10).