Actos BORME de Ostalazar Sl
11 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: MEDIAVILLA CESTEROS GEMA. Datos registrales. T 23117 , F 86, S 8, H M 52932, I/A 14 (4.02.20).
02 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: MEDIAVILLA FERRUZ NICOLAS. Datos registrales. T 23117 , F 84, S 8, H M 52932, I/A 13(25.06.19).
26 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: CESTEROS GROSSO MARIA SOLEDAD;MEDIAVILLA FERRUZ NICOLAS;MEDIAVILLACESTEROS NICOLAS. Nombramientos. Consejero: MEDIAVILLA CESTEROS JORGE. Con.Delegado: MEDIAVILLA CESTEROSJORGE. Datos registrales. T 23117 , F 83, S 8, H M 52932, I/A 12 (16.03.18).
12 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL MANUEL. Datos registrales. T 23117 , F 83, S 8, H M 52932,I/A 11 ( 5.02.15).
27 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: MEDIAVILLA CESTEROS NICOLAS. Con.Delegado: MEDIAVILLA CESTEROS NICOLAS.Nombramientos. Secretario: CESTEROS GROSSO MARIA SOLEDAD. Cons.Del.Sol: CESTEROS GROSSO MARIASOLEDAD;MEDIAVILLA FERRUZ NICOLAS;NICOLAS MEDIAVILLA CESTEROS. Datos registrales. T 23117 , F 82, S 8, H M52932, I/A 10 (18.12.13).
19 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: CESTEROS GROSSO MARIA SOLEDAD. Nombramientos. Consejero: MEDIAVILLA CESTEROSNICOLAS. Presidente: MEDIAVILLA CESTEROS GEMMA. Secretario: MEDIAVILLA CESTEROS NICOLAS. Con.Delegado:MEDIAVILLA CESTEROS NICOLAS. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 242,91 Euros. Resultante Suscrito: 144.000,00Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 65.460,00 Euros. Resultante Suscrito: 209.460,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n.Sociedades absorbidas: ATELIER ESTHER SL. MEFU SL. Datos registrales. T 23117 , F 79, S 8, H M 52932, I/A 9 (10.12.13).
06 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apoderado: MEDIAVILLA CESTEROS JORGE. Datos registrales. T 3096 , F 134, S 8, H M 52932, I/A 8(27.10.09).