Actos BORME de Osteogenos Sl
04 de Noviembre de 2022Nombramientos. Auditor: SAIZ GUZMAN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 43036 , F 100, S 8, H M 338949, I/A 15(27.10.22).
14 de Marzo de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 201.860,00 Euros. Cambio de domicilio social. C/COBRE 13 (TORREJON DE ARDOZ). Datos registrales. T 19338 , F 199, S 8, H M 338949, I/A 14 ( 7.03.22).
14 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: SIERRA CORDON SILVIA. Datos registrales. T 19338 , F 199, S 8, H M 338949, I/A 13 ( 6.10.21).
05 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SIERRA CORDON GONZALO;PINEDA VERA CESAR;MIEZA BARTOLOME JUAN JOSE. Secretario:MIEZA BARTOLOME JUAN JOSE. Presidente: SIERRA CORDON GONZALO. Con.Delegado: SIERRA CORDON GONZALO.Nombramientos. Auditor: SAIZ GUZMAN AUDITORES SLP. Adm. Solid.: SIERRA CORDON GONZALO;PINEDA VERA CESAR.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales.T 19338 , F 199, S 8, H M 338949, I/A 12 (25.02.19).
02 de Agosto de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 203.100,00 Euros. Datos registrales. T 19338 , F 198, S 8,H M 338949, I/A 11 (25.07.18).
06 de Junio de 2018Nombramientos. Auditor: SAIZ GUZMAN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 19338 , F 198, S 8, H M 338949, I/A 10(30.05.18).
21 de Febrero de 2017Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 8 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 19338 , F 197, S 8, H M338949, I/A 9 (14.02.17).
08 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: PINEDA VERA CESAR;SIERRA CORDON SILVIA. Datos registrales. T 19338 , F 196, S 8, H M338949, I/A 8 (28.07.16).
08 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES CASTRILLO MARIA DEL CARMEN;SIERRA CORDON GONZALO;PINEDA VERA CESAR.Secretario: SIERRA CORDON GONZALO. Presidente: TORRES CASTRILLO MARIA DEL CARMEN. Con.Delegado: TORRESCASTRILLO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: SIERRA CORDON GONZALO;PINEDA VERA CESAR;MIEZABARTOLOME JUAN JOSE. Datos registrales. T 19338 , F 195, S 8, H M 338949, I/A 6 (30.06.16).
Nombramientos. Secretario: MIEZA BARTOLOME JUAN JOSE. Presidente: SIERRA CORDON GONZALO. Con.Delegado: SIERRACORDON GONZALO. Datos registrales. T 19338 , F 196, S 8, H M 338949, I/A 7 (30.06.16).
21 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TORRES CASTRILLO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: TORRES CASTRILLOMARIA DEL CARMEN;SIERRA CORDON GONZALO;PINEDA VERA CESAR. Secretario: SIERRA CORDON GONZALO. Presidente:TORRES CASTRILLO MARIA DEL CARMEN. Con.Delegado: TORRES CASTRILLO MARIA DEL CARMEN. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social.C/ MANZANOS 36 - POLIGONO INDUSTRIAL LA HOYA (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 19338 , F 195, S8, H M 338949, I/A 5 (11.07.11).
14 de Enero de 2009Cambio de domicilio social. C/ EMILIANO BARRAL 5-B - LOCAL (MADRID). Datos registrales. T 19338 , F 194, S 8, H M 338949,I/A 4 (30.12.08).