Actos BORME de Ourensalia Xestions Medioambientais Sl
25 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO VILLARON ORLANDO;ESTEVEZ VAZQUEZ JOSE DANIEL;CABANELAS CALVELO JOSEPERFECTO;ESTEVEZ VAZQUEZ JOSE DANIEL. Datos registrales. T 869 , F 77, S 8, H OR 11422, I/A 24 (10.02.21).
07 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CABANELAS CALVELO JOSE PERFECTO;RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Presidente: CABANELASCALVELO JOSE PERFECTO. Secretario: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Consejero: ESTEVEZ VAZQUEZ JOSE DANIEL.Nombramientos. Adm. Solid.: ZORITA LEES MIGUEL;MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administrador 煤nico. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 869 , F 76, S 8, H OR 11422, I/A 23 (27.03.17).
10 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ZORITA LEES MIGUEL;MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datos registrales. T 869 , F 75, S 8,H OR 11422, I/A 22 ( 2.11.16).
05 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO. Nombramientos. Consejero: ESTEVEZ VAZQUEZ JOSE DANIEL. Apo.Man.Soli: ESTEVEZ VAZQUEZ JOSE DANIEL.Datos registrales. T 854 , F 9, S 8, H OR 11422, I/A 21 (27.01.16).
12 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DAORJE MEDIOAMBIENTE SA. Revocaciones. Apo.Sol.: MURIEL JIMENEZ JOSEMANUEL;HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Apo.Manc.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Apoderado: HIDALGO TRUCIOSJOAQUIN. Nombramientos. Consejero: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO;CABANELAS CALVELO JOSE PERFECTO;RUBIOGARCIA MARIA CRUZ. Presidente: CABANELAS CALVELO JOSE PERFECTO. Secretario: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ.Apo.Man.Soli: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO;RUBIO GARCIA MARIA CRUZ;CABANELAS CALVELO JOSE PERFECTO. Datosregistrales. T 854 , F 7, S 8, H OR 11422, I/A 20 ( 2.06.15).
23 de Diciembre de 2014Otros conceptos: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social.(a) La promoci贸n, participaci贸n y gesti贸n de negocios y actividades de los sectores primario, industrial, de construcci贸n y de servicios,relacionados con la protecci贸n y recuperaci贸n del medio ambiente y con el aprovechamiento y utilizaci贸n racional de los recursosnaturales, incluidos los energ茅ti. Datos registrales. T 854 , F 6, S 8, H OR 11422, I/A 19 (12.12.14).
29 de Octubre de 2014Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 854 , F 6, S 8, H OR 11422, I/A 18( 9.10.14).
15 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: RIVERA PEREZ ANGEL. Nombramientos. Apoderado: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO. Datosregistrales. T 827 , F 69, S 8, H OR 11422, I/A 17 ( 5.09.14).
30 de Diciembre de 2013Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 827 , F 69, S 8, H OR 11422, I/A16 (18.12.13).
25 de Enero de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Apo.Manc.: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Nombramientos.Apo.Sol.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 827 , F 67, S 8, HOR 11422, I/A 15 (14.01.13).
24 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ESTEVEZ VAZQUEZ JOSE DANIEL;DAORJE MEDIOAMBIENTE SA. Nombramientos. Adm.Unico: DAORJE MEDIOAMBIENTE SA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoresmancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 827 , F 67, S 8, H OR 11422, I/A 13 ( 9.08.12).
05 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Datos registrales. T 800 , F 81, S 8, H OR 11422, I/A 12 (24.05.12).
26 de Agosto de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: DAORJE MEDIOAMBIENTE SA. Ceses/Dimisiones. Adm.Mancom.: DANIGAL SA. Nombramientos. Adm. Mancom.: DAORJE MEDIOAMBIENTE SA. Datos registrales. T 800 , F 79, S 8, HOR 11422, I/A 9 ( 8.08.11).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.010,00 Euros. Datos registrales. T 800 , F 79, S 8, H OR11422, I/A 10 ( 8.08.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: GIL RODRIGUEZ RAMON. Nombramientos. Apo.Manc.: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Apo.Sol.:VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Datos registrales. T 800 , F 80, S 8, H OR 11422, I/A 11 ( 8.08.11).
07 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 800 , F 78, S 8, H OR 11422, I/A 8 (26.01.11).
03 de Febrero de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL;ALONSO VILLARON JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: GILRODRIGUEZ RAMON;HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN;RIVERA PEREZ ANGEL. Datos registrales. T 765 , F 83, S 8, H OR 11422,I/A 7 (12.01.10).
09 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Datos registrales. T 765 , F 82, S 8, H OR 11422, I/A 5 (22.05.09).