Actos BORME de Ourensana De Gas Sl
17 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ MARTINEZ ISABEL;PEREZ BELLIDO FARA. Vicepresid.: PEREZ BELLIDO FARA. Datosregistrales. T 928 , F 106, S 8, H OR 12399, I/A 7 ( 8.11.23).
21 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Nombramientos. Consejero: PEREZ MARTINEZ ISABEL. Datosregistrales. T 798 , F 153, S 8, H OR 12399, I/A 6 (11.04.21).
19 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ GARRIDO JOSE MANUEL;GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS;GARRIDO BERNARDEZMARIA DEL CARMEN;PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ BELLIDO FARA. Presidente: PEREZ GARRIDO JOSE MANUEL.Vicepresid.: PEREZ BELLIDO FARA. Secretario: GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS. Vicesecret.: GARRIDO BERNARDEZMARIA DEL CARMEN. Con.Delegado: GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS. Nombramientos. Consejero: GARRIDOBERNARDEZ JOSE CARLOS. Presidente: GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS. Consejero: PEREZ BELLIDO FARA. Vicepresid.:PEREZ BELLIDO FARA. Consejero: GARRIDO REGA ALVARO. Secretario: GARRIDO REGA ALVARO. Consejero: PEREZGARRIDO JOSE MANUEL. Vicesecret.: PEREZ GARRIDO JOSE MANUEL. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Con.Delegado:GARRIDO REGA ALVARO. Dir. General: GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 798 , F 152, S 8, H OR12399, I/A 4 (10.09.18).
Nombramientos. Apoderado: GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 798 , F 153, S 8, H OR 12399, I/A 5(10.09.18).
11 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 31.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 61.000,00 Euros. Datos registrales. T 798 , F 152, S 8, H OR12399, I/A 3 (28.04.10).
22 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS. Nombramientos. Consejero: PEREZ GARRIDO JOSEMANUEL;GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS;GARRIDO BERNARDEZ MARIA DEL CARMEN;PEREZ NIETO JOSERAMON;PEREZ BELLIDO FARA. Presidente: PEREZ GARRIDO JOSE MANUEL. Vicepresid.: PEREZ BELLIDO FARA. Secretario:GARRIDO BERNARDEZ JOSE CARLOS. Vicesecret.: GARRIDO BERNARDEZ MARIA DEL CARMEN. Con.Delegado: GARRIDOBERNARDEZ JOSE CARLOS. Ampliaci贸n de capital. Capital: 19.130,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.000,00 Euros.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Otrosconceptos: Modificaci贸n del art铆culo 16, referente a que se a帽ade un nuevo p谩rrafo, en el que se tomar谩n por mayor铆a del noventapor ciento de los votos algunos acuerdos y 32 de los Estatutos Sociales, indicando que se someter谩 a arbitraje de equidadaquellascuestiones que surjan entre los socios. Datos registrales. T 798 , F 151, S 8, H OR 12399, I/A 2 ( 5.02.10).
04 de Diciembre de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.11.09. Objeto social: a) La explotaci贸n de Agencias distribuidoras de G.L.P. -gaseslicuados delpetr贸leo-, y dem谩s productos o subproductos que la concesionaria le suministre, con sus labores anexas ycomplementarias a las mismas -venta de materiales auxiliares, el reparto domiciliario-. b) La realizaci贸n de labores de. Domicilio: AVDADE SANTIAGO 15 BAJO (OURENSE). Capital: 10.870,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: GARRIDO BERNARDEZ JOSECARLOS. Datos registrales. T 798 , F 149, S 8, H OR 12399, I/A 1 (23.11.09).