Actos BORME de Ovelar Sa
15 de Febrero de 2023Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 32 de los estatutos sociales estableciendo el car谩cter retribuido del cargo deadministrador. Datos registrales. T 25117 , F 105, S 8, H M 85509, I/A 70 ( 8.02.23).
17 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: HERREROS PANIAGUA JUAN RAMON. Datos registrales. T 25117 , F 105, S 8, H M 85509, I/A 69(10.01.23).
25 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: QUESADA GONZALEZ JORGE. Datos registrales. T 25117 , F 104, S 8, H M 85509, I/A 68(18.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: RIERA LLARENA MERCEDES;RIERA LLARENA MERCEDES. Datos registrales. T 25117 , F 104, S 8,H M 85509, I/A 67 (28.10.22).
17 de Octubre de 2022Nombramientos. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 25117 , F 104, S 8, H M85509, I/A 66 ( 9.10.22).
01 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: OVELAR CALVO MANUEL;OVELAR GALACHE JULIA;RIERA LLARENA MERCEDES. Datosregistrales. T 25117 , F 103, S 8, H M 85509, I/A 65 (24.09.20).
28 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 25117 , F 103, S 8, H M 85509, I/A 64 (21.10.19).
07 de Octubre de 2019Reelecciones. Con.Delegado: OVELAR CALVO JESUS. Consejero: OVELAR CALVO JESUS. Presidente: OVELAR CALVO JESUS.Consejero: OVELAR GALACHE JULIA;OVELAR CALVO MANUEL. Datos registrales. T 25117 , F 103, S 8, H M 85509, I/A 63(30.09.19).
23 de Junio de 2017Otros conceptos: La sociedad ha participado en la constituci贸n de la uni贸n temporal de empresas denominada DIDOSEG OVELARUNION TEMPORAL DE EMPRESAS, TITULOS USC", LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO. Datos registrales. T 25117 , F 102, S 8, H M85509, I/A 62 (14.06.17).
14 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 25117 , F 102, S 8, H M 85509, I/A 60 ( 3.11.16).
07 de Marzo de 2016Ampliacion del objeto social. La fabricaci贸n y comercializaci贸n de soluciones para el desarrollo de productos y campa帽as demerchandising y comunicaci贸n visual, soportes para etiquetas electr贸nicas y otros, porta-precios, carteler铆a a茅rea y expositores deproductos. La compraventa, alquiler, reparaci贸n y mantenimiento de maquina. Datos registrales. T 25117 , F 102, S 8, H M 85509, I/A59 (26.02.16).
07 de Marzo de 2014Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 25117 , F 101, S 8, H M 85509, I/A 58 (27.02.14).
27 de Diciembre de 2013Reelecciones. Secretario: VASSALLO Y MORENO ALBERTO. Con.Delegado: OVELAR CALVO JESUS. Consejero: OVELARCALVO JESUS. Presidente: OVELAR CALVO JESUS. Consejero: OVELAR GALACHE JULIA;OVELAR CALVO MANUEL. Datosregistrales. T 25117 , F 101, S 8, H M 85509, I/A 57 (19.12.13).
26 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: OVELAR CALVO MANUEL. Datos registrales. T 25117 , F 101, S 8, H M 85509, I/A 56 (17.04.13).
08 de Marzo de 2012Revocaciones. Apoderado: VILLA GUINEA FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 25117 , F 99, S 8, H M 85509, I/A 54(28.02.12).
Nombramientos. Apoderado: RIERA LLARENA MERCEDES. Datos registrales. T 25117 , F 100, S 8, H M 85509, I/A 55 (28.02.12).
23 de Diciembre de 2010Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. A. LA MANIPULACION Y VENTADE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EN TODOS SUS CONCEPTOS; B. LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DEETIQUETAS ADHESIVAS Y DE CARTULINA CON BASE DE PAPEL O MATERIALES SINTETICOS.. Datos registrales. T 25117 , F97, S 8, H M 85509, I/A 52 ( 9.12.10).
Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T25117 , F 99, S 8, H M 85509, I/A 53 (13.12.10).
27 de Octubre de 2010Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ACCESORIOS PARA EL COMERCIO SA. Datos registrales. T 25117 , F 96, S 8, HM 85509, I/A 51 (14.10.10).
02 de Agosto de 2010Otros conceptos: ABSORBENTE: OVELAR, SA, Arganda del Rey -Madrid-Avenida Guijar, 17, CIF A28712479, tomo 5222, folio 41,Hoja M-85509.ABSORBIDA: ACCESORIOS PARA EL COMERCIO, S.A, Emilio Ferrari 96Madrid, CIF A80340680, tomo 3088, folio165, hoja M52802. Datos registrales. T 5222 , F 43, S 8, H M 85509, I/A 19M (21.07.10).
30 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: RIOS CASTELLET JOSE MIGUEL. Consejero: CORPORACION SANT BERNAT SA. Datosregistrales. T 25117 , F 95, S 8, H M 85509, I/A 50 (20.07.10).
02 de Marzo de 2010Revocaciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP.Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 25117 , F 95, S 8, H M 85509, I/A 49 (18.02.10).
11 de Mayo de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 118.160,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.527.280,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 1.101.520,00 Euros. Desembolsado: 1.101.520,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.628.800,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 3.628.800,00 Euros. Datos registrales. T 25117 , F 95, S 8, H M 85509, I/A 48 (28.04.09).