Actos BORME de Ovisa Pavimentos Y Obras Sl
09 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ RAMIRO ENRIQUE. Datos registrales. T 414 , F 163, S 8, H LU 627, I/A 76 (22.09.23).
12 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 163, S 8, H LU 627, I/A 75(30.11.22).
05 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CHOISEL PHILIPPE GERARD;UGUET CANAL NURIA. Datos registrales. T 414 , F 163, S 8, H LU 627,I/A 74 (27.07.22).
16 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: LI脩EIRA MOSQUERA SANDRA. Datos registrales. T 414 , F 162, S 8, H LU 627, I/A 72 ( 4.12.19).
21 de Noviembre de 2019Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: AUDITGAL SA;KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 162, S 8, H LU 627, I/A 71 ( 6.11.19).
27 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 162, S 8, H LU 627, I/A 70 (14.02.19).
13 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BURRIEL SUSANA. Datos registrales. T 414 , F 161, S 8, H LU 627, I/A 68 (28.01.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ OLIAS ROBERTO;FERNANDEZ CASAS RAFAEL EDUARDO;SAN MARTIN FERREIRO JUAN.Datos registrales. T 414 , F 161, S 8, H LU 627, I/A 69 (28.01.19).
07 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: SAN MARTIN FERREIRO JUAN. Datos registrales. T 414 , F 160, S 8, H LU 627, I/A 67 (16.01.18).
24 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 160, S 8, H LU 627, I/A 66 ( 9.01.18).
24 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE LA MESA DIAZ DEL RIO JOSE RAMON. Datos registrales. T 414 , F 159, S 8, H LU627, I/A 65 (11.08.17).
10 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: LOPEZ OLIAS ROBERTO. Datos registrales. T 414 , F 159, S 8, H LU 627, I/A 64 (27.10.16).
20 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: AMAGO VERDUGO CARMEN. Datos registrales. T 414 , F 159, S 8, H LU 627, I/A 63 (12.11.15).
16 de Noviembre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 62 ( 5.11.15).
06 de Agosto de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: VILANOVA VILA JOSE LUIS. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 60 B (14.03.14).
09 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: CILLERUELO TROTTER JOSE ANGEL. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 61(26.02.15).
24 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: VILANOVA VILA JOSE LUIS. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 60 (14.03.14).
30 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 59 (22.10.13).
05 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA RODOLFO. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 58 (27.06.13).
26 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: BLANCO MARTIN DIONISIO. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 57 (19.04.13).
14 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: HERVE GABRIEL EDMOND GRILLOT;MARTINEZ AYESTARAN JOSE MARIA;GOLES BARRIENTOSYERKO ALEJANDRO. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 56 ( 2.02.12).
26 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MONGE ISABEL. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 54 ( 9.07.11).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MONGE ISABEL. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 55 ( 9.07.11).
15 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 53 (29.11.10).
20 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: GOLES BARRIENTOS YERKO ALEJANDRO. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 52( 2.09.10).
11 de Marzo de 2010Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SA. Datos registrales. T 414 , F157, S 8, H LU 627, I/A 51 (26.02.10).