Actos BORME de Ow Fs Offshore Sa
06 de Noviembre de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42518 , F 119, S 8, H M 752302, I/A 11 (28.10.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAINO MATTEO. Nombramientos. Consejero: SILVA MOREIRA MIGUEL COSTA. Datosregistrales. T 42518 , F 119, S 8, H M 752302, I/A 12 (28.10.23).
Revocaciones. Apo.Manc.: MAINO MATTEO. Apo.Sol.: MAINO MATTEO. Datos registrales. T 42518 , F 119, S 8, H M 752302, I/A13 (28.10.23).
Nombramientos. Apoderado: GUERRERO MARTINEZ-BURGOS ALMUDENA. Datos registrales. T 45874 , F 20, S 8, H M 752302,I/A 14 (28.10.23).
16 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA CONDE NORIEGA EMILIO. Apo.Manc.: GARCIA CONDE NORIEGA EMILIO. Apo.Sol.: RIVERAVIZCARRONDO JAVIER. Apo.Manc.: RIVERA VIZCARRONDO JAVIER. Apo.Sol.: MARTIN SEGURADO ESTRELLA. Apo.Manc.:MARTIN SEGURADO ESTRELLA;MELO DE CASTRO BELO DUARTE;GORSKI GRZEGORZ. Apo.Sol.: MELO DE CASTRO BELODUARTE;GORSKI GRZEGORZ;MARTIN SEGURADO ESTRELLA. Datos registrales. T 42518 , F 119, S 8, H M 752302, I/A 10 (9.02.23).
03 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA CONDE NORIEGA EMILIO. Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ DEGREGORIO MOLINA JAVIER ISIDRO. Datos registrales. T 42518 , F 118, S 8, H M 752302, I/A 9 (27.01.23).
18 de Enero de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1,00 Euros. Desembolsado: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.338.183,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 19.338.183,00 Euros. Datos registrales. T 42518 , F 118, S 8, H M 752302, I/A 8 (11.01.22).
13 de Enero de 2022Nombramientos. Con.Delegado: RODRIGUEZ SANCHEZ BAUTISTA JULIO. Datos registrales. T 42518 , F 117, S 8, H M 752302,I/A 7 ( 5.01.22).
27 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MELO DE CASTRO BELO DUARTE;MARTINIS SPYRIDON. Con.Delegado: MARTINIS SPYRIDON.Nombramientos. Consejero: MAINO MATTEO;RODRIGUEZ SANCHEZ BAUTISTA JULIO. Datos registrales. T 42518 , F 117, S 8,H M 752302, I/A 6 (20.12.21).
07 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: MAINO MATTEO. Apo.Sol.: MAINO MATTEO. Datos registrales. T 42518 , F 110, S 8, H M 752302,I/A 3 (29.11.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: GORSKI GRZEGORZ. Apo.Manc.: GORSKI GRZEGORZ. Datos registrales. T 42518 , F 113, S 8, H M752302, I/A 4 (29.11.21).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DE GREGORIO MOLINA JAVIER ISIDRO. Datos registrales. T 42518 , F 116, S 8, H M752302, I/A 5 (29.11.21).
20 de Octubre de 2021Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA, N潞42, TORRE SPINOLA, (MADRID). Datos registrales. T 42518, F 110, S 8, H M 752302, I/A 2 (13.10.21).
21 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: COSTA SILVA MOREIRA MIGUEL. Datos registrales. T 4373 , F 213, S 8, H AS 55793, I/A 7 ( 9.06.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN SEGURADO ESTRELLA. Datos registrales. T 4373 , F 213, S 8, H AS 55793, I/A 8 ( 9.06.21).
22 de Abril de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 15.838.182,00 Euros. Desembolsado: 15.838.182,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.338.182,00Euros. Resultante Desembolsado: 19.338.182,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-.Datos registrales. T 4373 , F 212, S 8, H AS 55793, I/A 6 (14.04.21).
30 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: MANSO NETO JOAO MANUEL. Consejero: MANSO NETO JOAO MANUEL. Revocaciones.Apo.Sol.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Manc.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Apo.Sol.: MELO DE CASTRO BELO DUARTE.Apo.Manc.: MELO DE CASTRO BELO DUARTE. Apo.Sol.: MARTINIS SPYRIDON. Apo.Manc.: MARTINIS SPYRIDON.Nombramientos. Consejero: GORSKI GRZEGORZ. Con.Delegado: MARTINIS SPYRIDON. Presidente: GORSKI GRZEGORZ.Apo.Sol.: MELO DE CASTRO BELO DUARTE;GORSKI GRZEGORZ. Apo.Manc.: MELO DE CASTRO BELO DUARTE;GORSKIGRZEGORZ. Datos registrales. T 4373 , F 210, S 8, H AS 55793, I/A 5 (22.03.21).
30 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4373 , F 210, S 8, H AS 55793,I/A 4 (21.12.20).