Actos BORME de P3 Spain Logistic Parks Socimi Sa
08 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: DE LOS MOZOS MU脩OZ MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T 36311 , F 25, S 8, H M 625006, I/A33 (31.10.23).
10 de Octubre de 2023Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 36311 , F 24, S 8, H M625006, I/A 32 ( 3.10.23).
14 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Datos registrales. T 36311 ,F 24, S 8, H M 625006, I/A 31 ( 7.09.23).
06 de Septiembre de 2023Modificaciones estatutarias. Supresi贸n del apartado 2 del art铆culo 8潞 de los estatutos, supresi贸n del apartado 2 y la modificaci贸n delos apartados 3 y 4 del art铆culo 29潞 de los estatutos, modificaci贸n de los apartados 2 y 3 del art铆culo 30潞 de los estatutos, y modificaci贸ndel art铆culo 31潞 de los estatutos. Datos registrales. T 36311 , F 23, S 8, H M 625006, I/A 30 (30.08.23).
05 de Septiembre de 2023Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 13陋 el nombramiento de HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL comovicesecretaria segunda, siendo lo correcto vicesecretaria segunda no consejera. Datos registrales. T 36311 , F 11, S 8, H M 625006,I/A 13 ( 3.06.19).
28 de Julio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Presidente: MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Vicepr.2: MERIDAGARCIA FRANCISCO JAVIER. Revocaciones. Apo.Manc.: MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Nombramientos. Presidente:MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 36311 , F 23, S 8, H M 625006, I/A 29 (21.07.23).
22 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36311 , F 22, S 8, H M 625006, I/A 28 (15.11.22).
07 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36311 , F 22, S 8, H M 625006, I/A 27 (28.10.22).
27 de Septiembre de 2022Reelecciones. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36311 , F 22, S 8, H M 625006, I/A 26 (20.09.22).
27 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: SPENCER OTIS LEE;MARQUINA FERNANDEZ DAVID;SCHOULTZ KATIE JANE;HERNANDEZHERNANDEZ RAQUEL;HUA LEE HANG;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Nombramientos. Consejero: MERIDA GARCIAFRANCISCO JAVIER. Vicepr.2: MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: MARQUINA FERNANDEZ DAVID;SPENCEROTIS LEE;MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER;SCHOULTZ KATIE JANE;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Apo.Man.Soli:PEREZ ORTIZ ELENA. Apo.Manc.: HUA LEE HANG. Apo.Sol.: CAMARASALTAS GARRIDO ALBERTO;DE LOS MOZOS MU脩OZMARIA DEL ROSARIO. Cambio de domicilio social. C/ PINAR 7 - 1陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36311 , F 19, S 8,H M 625006, I/A 25 (20.06.22).
11 de Febrero de 2022P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 36311 , F 19, S 8, H M 625006, I/A 24 ( 4.02.22).
10 de Febrero de 2022Reelecciones. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36311 , F 19, S 8, H M 625006, I/A 23 ( 3.02.22).
16 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: TMF VAT & FISCAL REPRESENTATION SERVICES SPAIN SL. Apo.Manc.: MARQUINA FERNANDEZDAVID;SCHOULTZ KATIE JANE;HUA LEE HANG;ZAHRANE ADNANE. Datos registrales. T 36311 , F 19, S 8, H M 625006, I/A 22 (9.12.21).
15 de Septiembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7.266.979,00 Euros. Desembolsado: 7.266.979,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.615.479,00 Euros.Resultante Desembolsado: 12.615.479,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 36311 , F 17, S 8, H M 625006, I/A 21 ( 8.09.21).
21 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36311 , F 17, S 8, H M625006, I/A 20 (14.04.21).
10 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Vsecr1.NC: ORTEGA SANCHEZ RUBEN. Nombramientos. Vsecr1.NC: MONREAL JORDE VICTOR. Datosregistrales. T 36311 , F 16, S 8, H M 625006, I/A 19 ( 3.02.21).
27 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARRIGUES CALDERON MARIA-BELEN. VsecrNoConsj: ZAHONERO DE AGUEDA MARTA.Nombramientos. SecreNoConsj: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION. Vsecr1.NC: ORTEGA SANCHEZ RUBEN. Cambio dedomicilio social. C/ PINAR 7, 5 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 36311 , F 16, S 8, H M 625006, I/A 18 (20.11.19).
11 de Octubre de 2019Nombramientos. Consejero: WORBOYS IAN PETER. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 13陋 la publicaci贸n delnombramento de WORBOYS IAN PETER como consejero. Datos registrales. T 36311 , F 11, S 8, H M 625006, I/A 13 ( 3.06.19).
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: WORBOYS IAN PETER. Consejero: WORBOYS IAN PETER. Nombramientos. Consejero:SPENCER OTIS LEE. Vicepresid.: SPENCER OTIS LEE. Datos registrales. T 36311 , F 14, S 8, H M 625006, I/A 16 ( 4.10.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: MARQUINA FERNANDEZ DAVID;JANE SCHOULTZ KATIE;HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;WORBOYS IAN PETER;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Apo.Sol.: HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL.Nombramientos. Apoderado: SPENCER OTIS LEE;MARQUINA FERNANDEZ DAVID;SCHOULTZ KATIE JANE;HERNANDEZHERNANDEZ RAQUEL;HUA LEE HANG;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Datos registrales. T 36311 , F 14, S 8, H M 625006,I/A 17 ( 4.10.19).
12 de Junio de 2019Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 112, PLANTA CUARTA (MADRID). Datos registrales. T 36311 , F 14, S8, H M 625006, I/A 15 ( 5.06.19).
10 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: KONECNY MARTIN. Vicepresid.: MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Presidente: KONECNY MARTIN.Revocaciones. Apo.Manc.: KONECNY MARTIN. Nombramientos. Presidente: MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Vicepresid.:
Nombramientos. Apo.Manc.: WORBOYS IAN PETER;MARQUINA FERNANDEZ DAVID;SCHOULTZ KATIE JANE;HERNANDEZHERNANDEZ RAQUEL;HUA LEE HANG;ZAHRANE ADNANE. Apo.Sol.: HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Datos registrales. T36311 , F 12, S 8, H M 625006, I/A 14 ( 3.06.19).
01 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: AASE GEORGE. Presidente: AASE GEORGE. Revocaciones. Apo.Manc.: GARRIGUESCALDERON BELEN;MARQUINA FERNANDEZ DAVID;KONECNY MARTIN;AASE GEORGE. Nombramientos. Consejero: JANESCHOULTZ KATIE. Presidente: KONECNY MARTIN. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.p3spainsocimi.com. Datos registrales. T 36311 , F 10, S 8, H M 625006, I/A 11 (24.09.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: KONECNY MARTIN;MARQUINA FERNANDEZ DAVID;JANE SCHOULTZ KATIE;HERNANDEZHERNANDEZ RAQUEL. Datos registrales. T 36311 , F 10, S 8, H M 625006, I/A 12 (24.09.18).
02 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: GARRIGUES CALDERON BELEN;MARQUINA FERNANDEZ DAVID;KONECNY MARTIN;AASEGEORGE. Datos registrales. T 36311 , F 9, S 8, H M 625006, I/A 10 (20.12.17).
31 de Agosto de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.288.500,00 Euros. Desembolsado: 5.288.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.348.500,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.348.500,00 Euros. Datos registrales. T 34750 , F 17, S 8, H M 625006, I/A 8 (23.08.17).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: BELEN GARRIGUESCALDERON. VsecrNoConsj: ZAHONERO DE AGUEDA MARTA. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DEREGISTRO CO. Consejero: AASE GEORGE;KONECNY MARTIN;MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Presidente: AASE GEORGE.Vicepresid.: MARQUINA FERNANDEZ DAVID. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y Aprobaci贸n de nuevo Texto Refundidode los Estatutos Sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 34750 , F 18, S 8, H M 625006, I/A 9 (23.08.17).
10 de Agosto de 2017Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 34750 , F 17, S 8, H M625006, I/A 7 ( 2.08.17).
28 de Abril de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: VIDITELNY USPECH S.R.O. Datos registrales. T 34750 , F 16, S 8, H M 625006,I/A 6 (20.04.17).
25 de Abril de 2017Cambio de objeto social. 1. La adquisici贸n y promoci贸n de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 2. Latenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversi贸n en el mercado inmobiliario ("SOCIMIs") o en el deentidades no residentes en territorio espa帽ol que tengan el mismo objet. Datos registrales. T 34750 , F 16, S 8, H M 625006, I/A 5(11.04.17).
24 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: TMF VAT & FISCAL REPRESENTATION SERVICES SPAIN SL. Datos registrales. T 34750 , F 15, S8, H M 625006, I/A 4 (16.03.17).
23 de Marzo de 2017Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.000,00 Euros. Datos registrales. T 34750 , F 14, S 8, H M 625006, I/A 2(15.03.17).