Actos BORME de Palencia 3 Investigacion Desarrollo Y Explotacion Sl
05 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Liquidador: HERNANDO MARTINEZ-ARROYO MARGARITA CHANTAL. Consejero: ARRIETA CARRILLOTOMAS;RIVERA YSASI-YSASMENDI JOSE ANTONIO CIPRIANO;MERINO GONZALEZ ANGEL;FUNDACION INSTITUTOPETROFISICO;ABARCA CORRALES MARTA;ALONSO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: MERINO GONZALEZ ANGEL.Vicepresid.: ARRIETA CARRILLO TOMAS. Consejero: BASCU脩ANA PEREZ ALBERTO. SecreNoConsj: HERNANDO MARTINEZ-ARROYO MARGARITA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARRIETA CARRILLO TOMAS;MERINO GONZALEZ ANGEL;REMON GILMIGUEL ANGEL;ALVAREZ CORTINA VALENTIN. Nombramientos. Liquidador: HERNANDO MARTINEZ-ARROYO MARGARITACHANTAL. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 33824 , F 42, S 8, H M 608690, I/A 3 (29.01.19).
22 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: UGEDO ALVAREZ-OSSORIO JAVIER;ARAMBURU MAQUA IGNACIO;VIUDES SIMO RAMON.Nombramientos. Consejero: BASCU脩ANA PEREZ ALBERTO. Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 10 y 14 delos Estatutos Sociales.. Cambio de domicilio social. C/ ERIC KANDEL 1 (GETAFE). Datos registrales. T 33824 , F 41, S 8, H M608690, I/A 2 (10.09.15).
21 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: UGEDO ALVAREZ-OSSORIO JAVIER. Vicepresid.: MERINO GONZALEZ ANGEL. Nombramientos.Presidente: MERINO GONZALEZ ANGEL. Vicepresid.: ARRIETA CARRILLO TOMAS. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:20.124,00 Euros. Resultante Suscrito: 31.476,00 Euros. Datos registrales. T 441 , F 215, S 8, H P 6379, I/A 14 (13.05.15).
23 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA CUADRA MOYA JOSE LUIS;URBANO GARCIA JORGE. Nombramientos. Consejero:ABARCA CORRALES MARTA;ALONSO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: MERINO GONZALEZANGEL;FUNDACION INSTITUTO PETROFISICO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 53.400,00 Euros. Resultante Suscrito:51.600,00 Euros. Datos registrales. T 441 , F 215, S 8, H P 6379, I/A 13 (12.12.14).
29 de Enero de 2014Reelecciones. Consejero: UGEDO ALVAREZ-OSSORIO JAVIER;ARAMBURU MAQUA IGNACIO;VIUDES SIMO RAMON;ARRIETACARRILLO TOMAS;RIVERA YSASI-YSASMENDI JOSE ANTONIO CIPRIANO. Presidente: UGEDO ALVAREZ-OSSORIO JAVIER.Datos registrales. T 441 , F 215, S 8, H P 6379, I/A 12 (20.01.14).
28 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ORVIZ CASTRO FRANCISCO;DE DIOS GONZALEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 441 , F214, S 8, H P 6379, I/A 10 (18.12.12).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 225.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 105.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.14. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 441 , F 214, S 8, H P 6379, I/A 11 (18.12.12).
23 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 180.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 330.000,00 Euros. Datos registrales. T 441 , F 214, S 8, H P6379, I/A 7 (10.01.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ASUERO AZOGUIL DOMINGO. Nombramientos. Consejero: DE LA CUADRA MOYA, JOSE LUIS.Datos registrales. T 441 , F 214, S 8, H P 6379, I/A 8 (10.01.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ CORTINA VALENT N. Nombramientos. Consejero: FUNDACION INSTITUTOPETROFISICO. Datos registrales. T 441 , F 214, S 8, H P 6379, I/A 9 (10.01.12).
18 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MAZA LUQUE FRANCISCO. Vicepresid.: DE MIGUEL ESTEBAN FERNANDO. Consejero: DEMIGUEL ESTEBAN FERNANDO. Nombramientos. Consejero: MERINO GONZALEZ ANGEL;URBANO GARCIA JORGE. Datosregistrales. T 441 , F 213, S 8, H P 6379, I/A 5 ( 7.04.11).
Nombramientos. Vicepresid.: MERINO GONZALEZ ANGEL. Datos registrales. T 441 , F 213, S 8, H P 6379, I/A 6 ( 7.04.11).
01 de Abril de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ CORTINA VALENTIN;MARTINEZ DIAZ CARLOS;MALDONADO ZAMORA ALFONSO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARRIETA CARRILLO TOMAS;MERINO GONZALEZ ANGEL;REMON GIL MIGUELANGEL;ALVAREZ CORTINA VALENTIN. Datos registrales. T 441 , F 212, S 8, H P 6379, I/A 4 (14.03.11).
14 de Septiembre de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.06.10. Objeto social: La investigaci贸n, desarrollo, construcci贸n, operaci贸n,mantenimiento y explotaci贸n de almacenamientos subterr谩neos de di贸xido de carbono u otros recursos de la secci贸n B seg煤n ladefinici贸n de la Ley de Minas, Ley 22/1973, uotra que resulte de aplicaci贸n, as铆 como de plantas de tratamiento, infrae. Domicilio:CTRA DE PALENCIA - RIA脩O Km 97,34886 (VELILLA DEL RIO CARRION). Capital: 150.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: DE MIGUEL ESTEBAN FERNANDO;ARRIETA CARRILLO TOMAS;ALVAREZ CORTINA VALENTIN;DE DIOS GONZALEZJOSE CARLOS;ORVIZ CASTRO FRANCISCO;MAZA LUQUE FRANCISCO;ASUERO AZOGUIL DOMINGO;UGEDO ALVAREZ-OSSORIO JAVIER;VIUDES SIMO RAMON;ARAMBURU MAQUA IGNACIO;RIVERA YSASI-YSASMENDI JOSE ANTONIOCIPRIANO. Datos registrales. T 441 , F 210, S 8, H P 6379, I/A 1 (26.08.10).
Nombramientos. Presidente: UGEDO ALVAREZ-OSSORIO JAVIER. Vicepresid.: DE MIGUEL ESTEBAN FERNANDO.SecreNoConsj: HERNANDO MARTINEZ- ARROYO MARGARITA. Datos registrales. T 441 , F 211, S 8, H P 6379, I/A 2 (26.08.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MALDONADO ZAMORA ALFONSO;MARTINEZ DIAZ CARLOS;ALVAREZ CORTINA VALENTIN.Datos registrales. T 441 , F 211, S 8, H P 6379, I/A 3 (26.08.10).