Buscador CIF Logo

Actos BORME Paleta Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Paleta Sl

Actos BORME Paleta Sl - B01552264

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Alava para Paleta Sl con CIF B01552264

馃敊 Perfil de Paleta Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alava

Actos BORME de Paleta Sl

22 de Noviembre de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ASISTENCIAS CARTER S.L. Datos registrales. T 1761 , F 168, S8, H VI 18378, I/A 21 ( 7.11.23).

Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1761 , F 168, S 8, H VI 18378, I/A 22 ( 7.11.23).

27 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO. Datos registrales. T 1761 , F 167, S 8, H VI 18378, I/A 20(17.04.23).

09 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:BLANCO JUAREZ PABLO. Apo.Manc.: LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS;LOPEZ GARCIAALICIA;BACHS LOBO JAIME. Datos registrales. T 1737 , F 32, S 8, H VI 18378, I/A 19 (17.02.23).

22 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: ORTEGA CARBALLO JORGE. Nombramientos. Representan: BACHS LOBO JAIME. Datosregistrales. T 1737 , F 32, S 8, H VI 18378, I/A 18 ( 2.12.22).

17 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BACEIREDO GARCIA VICTOR. Apo.Manc.: ORTEGA CARBALLO JORGE;MARTIN FRANCOSILVIA;LOPEZ GARCIA ALICIA;DE LA FUENTE SOTOMAYOR FRANCISCO JAVIER;LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD;DEVLINRORY FRANCIS;BACHS LOBO JAIME. Datos registrales. T 1737 , F 29, S 8, H VI 18378, I/A 17 (25.10.22).

06 de Julio de 2022
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Ampliacion del objeto social. i) El transporte y laasistencia en carretera de veh铆culos. Transporte de mercancias por carretera; y ii) La reparaci贸n de veh铆culos de todo tipo y eltransporte de los mismos para su reparaci贸n.- Datos registrales. T 1737 , F 28, S 8, H VI 18378, I/A 16 (27.06.22).

18 de Abril de 2022
Fe de erratas: El nombre del apoderado inscrito en la inscripci贸n 13陋 de esta hoja es "VICTOR Baceiredo Garc铆a,". Datosregistrales. T 1737 , F 28, S 8, H VI 18378, I/A 15 (30.03.22).

01 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERRERO BARNETO JOAQUIN. Datos registrales. T 1737 , F 28, S 8, H VI 18378, I/A 14(23.03.22).

02 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ GARCIA ALICIA. Apo.Sol.: DANEO CERRO JOSE JAVIER;FERNANDEZ OLIVAABEL;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DE LOS COBOS EUGENIA;MARTINEZ NIETO LAURA;MARTOS PRATRODRIGO;SANCHEZ BOLUDA LUCIA;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA;DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI ANDRES.Apo.Man.Soli: MARTIN FRANCO SILVIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: ORTEGACARBALLO JORGE;LOPEZ GARCIA ALICIA;LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS. Apo.Sol.: LOPEZGARCIA ALICIA;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Apo.Man.Soli: DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO. Apo.Manc.: ORTEGACARBALLO JORGE;MARTIN FRANCO SILVIA;LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS. Datos registrales. T1665 , F 125, S 8, H VI 18378, I/A 12 (20.01.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BACEIREDO GARCIA VICTOR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BACEIREDO GARCIA VICENTE.Apo.Manc.: ORTEGA CARBALLO JORGE. Datos registrales. T 1665 , F 130, S 8, H VI 18378, I/A 13 (20.01.22).

31 de Agosto de 2021
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social.. Cambio de domicilio social. C/ ARTAPADURA,NUMERO 15.- (VITORIA-GASTEIZ). Datos registrales. T 1665 , F 124, S 8, H VI 18378, I/A 11 (10.08.21).

12 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: DUDE ALVAREZ ESTEFANIA;DUDE ALVAREZ ESTEFANIA. Apo.Man.Soli: GENER MARTINEZLAIA;GUELL BLASI ALICIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: ORTEGA CARBALLOJORGE;PONGRACZ VILMOS;DEVLIN RORY FRANCIS. Datos registrales. T 1665 , F 122, S 8, H VI 18378, I/A 10 (23.08.19).

20 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BACEIREDO GARCIA VICTOR. Apo.Manc.: GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO;DUDEALVAREZ ESTEFANIA. Datos registrales. T 1625 , F 42, S 8, H VI 18378, I/A 6 ( 5.12.18).

Ceses/Dimisiones. Representan: GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO. Nombramientos. Representan: ORTEGA CARBALLOJORGE. Otros conceptos: Se revoca la designaci贸n de DON PABLO GARRIGA VAZ DE CONCICAO, como persona f铆sicarepresentante de "ASISTENCIAS CARTER, S.L.", en el ejercicio de su cargo como administrador 煤nico de la sociedad "PALETA, S.L.",y se designa como sustituto a DON JORGE ORTEGA CARBALLO, con D.N.I. 53402990A.- Datos registrales. T 1665 , F 120, S 8, HVI 18378, I/A 7 ( 5.12.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUELL BLASI ALICIA;LOPEZ GARCIA ALICIA;GENER MARTINEZ LAIA. Apo.Manc.: ORTEGACARBALLO JORGE;PONGRACZ VILMOS;DEVLIN RORY FRANCIS. Datos registrales. T 1665 , F 120, S 8, H VI 18378, I/A 8 (5.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: DANEO CERRO JOSE JAVIER;FERNANDEZ OLIVA ABEL;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DE LOSCOBOS EUGENIA;MARTINEZ NIETO LAURA;MARTOS PRAT RODRIGO;SANCHEZ BOLUDA LUCIA;VARELA-GRANDAL RUIBALANA PATRICIA;DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI ANDRES. Datos registrales. T 1665 , F 121, S 8, H VI 18378, I/A 9 ( 5.12.18).

08 de Mayo de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUAS IRATXE S.L. Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ MENDOANTONIO;MORENO DE LA CRUZ BIENVENIDO;IZARRA LUENGAS GERMAN. Presidente: IZARRA LUENGAS GERMAN.Secretario: MORENO DE LA CRUZ BIENVENIDO. Revocaciones. Apo.Sol.: IZARRA LUENGAS GERMAN;JIMENEZ MENDOANTONIO. Apoderado: MORENO DE LA CRUZ BIENVENIDO. Nombramientos. Adm. Unico: ASISTENCIAS CARTER S.L.Representan: GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 1625 , F 38, S 8, H VI 18378, I/A 4 (16.04.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERRERO BARNETO JOAQUIN. Apo.Manc.: GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO;DUDEALVAREZ ESTEFANIA. Datos registrales. T 1625 , F 39, S 8, H VI 18378, I/A 5 (17.04.18).

17 de Febrero de 2017
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 18.11.16. Objeto social: Reparaci贸n de veh铆culos de todo tipo y el transporte de los mismospara repararlos. Domicilio: C/ PORTAL DE GAMARRA, N潞 44 BAJO (VITORIA-GASTEIZ). Capital: 57.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: IZARRA LUENGAS GERMAN. Presidente: IZARRA LUENGAS GERMAN. Consejero: MORENO DE LA CRUZBIENVENIDO. Secretario: MORENO DE LA CRUZ BIENVENIDO. Consejero: JIMENEZ MENDO ANTONIO. Datos registrales. T1625 , F 35, S 8, H VI 18378, I/A 1 ( 2.02.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: IZARRA LUENGAS GERMAN;JIMENEZ MENDO ANTONIO. Datos registrales. T 1625 , F 38, S 8, H VI18378, I/A 2 ( 6.02.17).

Nombramientos. Apoderado: MORENO DE LA CRUZ BIENVENIDO. Datos registrales. T 1625 , F 38, S 8, H VI 18378, I/A 3 (6.02.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n