Buscador CIF Logo

Actos BORME Palpan Castilla Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Palpan Castilla Sa

Actos BORME Palpan Castilla Sa - A34178301

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Cantabria para Palpan Castilla Sa con CIF A34178301

馃敊 Perfil de Palpan Castilla Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Cantabria

Actos BORME de Palpan Castilla Sa

13 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: OPINIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1205 , F 110, S 8, H S 33342, I/A 8 (27.09.22).

09 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: SAN MARTIN ARCEFRANCISCO. Datos registrales. T 1205 , F 110, S 8, H S 33342, I/A 7 (29.08.22).

28 de Agosto de 2019
Nombramientos. Auditor: OPINIA AUDITORES SLP. Modificaciones estatutarias. Se modifica el art. 19 de los estatutos socialesrelaivo a la forma de convocatoria de la junta general.-. Datos registrales. T 1205 , F 110, S 8, H S 33342, I/A 6 (20.08.19).

25 de Julio de 2019
Revocaciones. Apoderado: MAGALLANES FERNANDEZ CAYETANO. Datos registrales. T 1205 , F 109, S 8, H S 33342, I/A 5(18.07.19).

12 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN ARCE FRANCISCO;RAMON VILA JORGE;ARRIOLA MURRIETA JOSE MANUEL.Datos registrales. T 1205 , F 108, S 8, H S 33342, I/A 4 ( 4.07.19).

25 de Abril de 2019
Cambio de domicilio social. POLIG IND. DE CANDINA, C/ RIO PISUE脩A, S/N. (SANTANDER). Datos registrales. T 1205 , F 77, S8, H S 33342, I/A 1 (15.04.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS;MARTINEZ VILLAGRA MARIA ISABEL;MARTINEZ VILLAGRAFERNANDO. Cons.Del.Sol: MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Secretario: MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Cons.Del.Sol:MARTINEZ VILLAGRA CARLOS. Presidente: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZVILLAGRA CARLOS. Reelecciones. Auditor: KRESTON IBERAUDIT CYL SLP. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Como consecuencia el cambio de 贸rgano de administraci贸n semodifican los art铆culos 14, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34 y 38. Y se modificad el art铆culo 16 referente al n煤mero obligatorio de juntasgenerales ordinarias a celebrar durante el a帽o. Datos registrales. T 1205 , F 107, S 8, H S 33342, I/A 2 (15.04.19).

Revocaciones. Apoderado: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Datos registrales. T 1205 , F 108, S 8, H S 33342, I/A 3(15.04.19).

05 de Diciembre de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.329.285,60 Euros. Resultante Suscrito: 68.508,40 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 2.400.000,00 Euros. Desembolsado: 2.400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.468.508,40 Euros. ResultanteDesembolsado: 2.468.508,40 Euros. Datos registrales. T 449 , F 69, S 8, H P 3232, I/A 51 (28.11.18).

14 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: KRESTON IBERAUDIT CYL SLP. Datos registrales. T 449 , F 68, S 8, H P 3232, I/A 50 ( 5.02.18).

29 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Datos registrales. T 449 , F 68, S 8, H P 3232, I/A 49(19.05.17).

26 de Abril de 2017
Revocaciones. Apoderado: MIGUEL ANGEL FLANDES GALLO;MIGUEL ANGEL FLANDES GALLO. Apo.Man.Soli: ROMANMEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA;HERNANDEZ COS MIRIAM ELVIRA. Apo.Sol.: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA.Nombramientos. Apoderado: MAGALLANES FERNANDEZ CAYETANO. Datos registrales. T 449 , F 67, S 8, H P 3232, I/A 48(19.04.17).

12 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL;PADARNO UNO SL;AESIR GESTORA DE INVERSIONESSLU. Presidente: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL. SecreNoConsj: DE LA IGLESIA PRIETO IRUNE. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS;MARTINEZ VILLAGRA MARIA ISABEL;MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Datosregistrales. T 449 , F 67, S 8, H P 3232, I/A 46 ( 5.04.17).

Nombramientos. Presidente: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS. Secretario: MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Cons.Del.Sol:MARTINEZ VILLAGRA CARLOS;MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Datos registrales. T 449 , F 67, S 8, H P 3232, I/A 47 (5.04.17).

05 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 45(29.03.17).

02 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT KRESTON CYL SLP. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 43 (19.10.16).

Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT KRESTON CYL SLP. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 44 (19.10.16).

17 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE. Datos registrales. T 449 , F 66, S8, H P 3232, I/A 42 ( 8.03.16).

13 de Octubre de 2015
Reelecciones. Consejero: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL;PADARNO UNO SL;ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DECAPITAL RIESGO DE;AESIR GESTORA DE INVERSIONES SLU;INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL.Auditor: IBERAUDITKRESTON CYL SLP. Datos registrales. T 449 , F 65, S 8, H P 3232, I/A 40 ( 5.10.15).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: AESIR GESTORA DE INVERSIONES SLU. Reelecciones. SecreNoConsj: DE LA IGLESIAPRIETO IRUNE. Presidente: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 41 ( 5.10.15).

27 de Mayo de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 274.792,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.397.794,00 Euros. Datos registrales. T 449 , F65, S 8, H P 3232, I/A 39 (20.05.15).

08 de Abril de 2015
Modificaciones estatutarias. 19. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 449 , F 63, S 8, H P 3232, I/A 37 (27.03.15).

Revocaciones. Apoderado: VELASCO CELADA FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: ROMAN MEDIAVILLA RAQUELCARLOTA. Datos registrales. T 449 , F 64, S 8, H P 3232, I/A 38 (27.03.15).

12 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: LOMAS AUDITORES SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 449 , F 63, S 8, H P 3232, I/A 36 ( 4.12.14).

15 de Julio de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ COS MIRIAM ELVIRA;ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: HERNANDEZ COS MIRIAM ELVIRA;ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Datos registrales. T 449 , F 62, S 8,H P 3232, I/A 35 ( 8.07.14).

29 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: VELASCO CELADA FRANCISCO. Datos registrales. T 449 , F 62, S 8, H P 3232, I/A 34 (22.05.14).

25 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ADCOPA UNO S L. Presidente: ADCOPA UNO S L. Nombramientos. Consejero: GARCIASAAVEDRA ABOGADOS SL. Presidente: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL. Reelecciones. Auditor: LOMAS AUDITORES SLPROFESIONAL. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 954.495,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.672.586,00 Euros. Datosregistrales. T 449 , F 61, S 8, H P 3232, I/A 33 (18.09.13).

25 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: LOMAS AUDITORES SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 449 , F 61, S 8, H P 3232, I/A 32 (18.01.13).

16 de Octubre de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.536.736,95 Euros. Resultante Suscrito: 3.627.081,00 Euros. Datos registrales. T 449 , F61, S 8, H P 3232, I/A 31 ( 4.10.12).

07 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: VELASCO CELADA, FRANCISCO. Datos registrales. T 406 , F 56, S 8, H P 3232, I/A 30 (24.10.11).

29 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Auditor: LOMAS AUDITORES SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 406 , F 56, S 8, H P 3232, I/A 29 (19.09.11).

28 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL;ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITALRIESGO DE;IMPULSO DESARROLLO EMPRESARIAL SA SCR DE REGIMEN S;NELTOS SL;ORAVLA INVERSIONES SL.Presidente: ORAVLA INVERSIONES SL. Co.De.Ma.So: ORAVLA INVERSIONES SL. SecreNoConsj: DE LA IGLESIA PRIETO IRUNE.Nombramientos. Consejero: ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE;AESIR GESTORA DE INVERSIONESSLU;PADARNO UNO SL;ADCOPA UNO S L;INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL. Reelecciones. Auditor: LOMASAUDITORES SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 406 , F 55, S 8, H P 3232, I/A 27 (17.01.11).

Nombramientos. Presidente: ADCOPA UNO S L. Cons.Del.Sol: AESIR GESTORA DE INVERSIONES SLU. SecreNoConsj: DE LAIGLESIA PRIETO IRUNE. Datos registrales. T 406 , F 56, S 8, H P 3232, I/A 28 (17.01.11).

06 de Julio de 2010
Otros conceptos: Resoluci贸n de modificaci贸n de plazo en el expediente n潞 P/371/P07 de concesi贸n de Incentivos Regionales. Datosregistrales. T 406 , F 55, S 8, H P 3232, I/A n-1 (18.06.10).

04 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: CASIMIRO MEDIAVILLA AGUADO. Consejero: CASIMIRO MEDIAVILLA AGUADO;AESIRGESTORA DE INVERSIONES SLU. Reelecciones. Consejero: INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL. Auditor: LOMASAUDITORES SL. Datos registrales. T 406 , F 55, S 8, H P 3232, I/A 26 (22.12.09).

19 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA SAAVEDRA Y OREJON JULIO. Nombramientos. SecreNoConsj: DE LA IGLESIA PRIETOIRUNE. Datos registrales. T 406 , F 54, S 8, H P 3232, I/A 23 ( 9.01.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA. Nombramientos. Consejero:INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL;ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE. Reelecciones. Auditor:LOMAS AUDITORES SL. Datos registrales. T 406 , F 54, S 8, H P 3232, I/A 24 ( 9.01.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: EMILIO MEDIAVILLA AGUADO. Datos registrales. T 406 , F 55, S 8, H P 3232, I/A 25 ( 9.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n