Buscador CIF Logo

Actos BORME Pamecal Sociedad Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pamecal Sociedad Anonima

Actos BORME Pamecal Sociedad Anonima - A20168571

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Guipuzcoa para Pamecal Sociedad Anonima con CIF A20168571

🔙 Perfil de Pamecal Sociedad Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Guipuzcoa

Actos BORME de Pamecal Sociedad Anonima

15 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VNPI GLOBAL INVESTMENTS & SERVICES SL. Revocaciones. Socio único: VNPI GLOBALINVESTMENTS & SERVICES SL. Apoderado: GARRETTE STEVEN L. Apo.Man.Soli: HERRANZ GARCIA MARIALUISA;ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUEL ALBERTO;OLIVER GIMENO RAFAEL;MUÑOZ MURILLO YOLANDA;MUÑOZMURILLO YOLANDA. Apo.Sol.: ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUEL ALBERTO;MARTINEZ MAESO LORENZO. Apo.Manc.:HERRANZ GARCIA MARIA LUISA;ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUEL ALBERTO;OLIVER GIMENO RAFAEL. Apo.Man.Soli:ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUEL ALBERTO;HERRANZ GARCIA MARIA LUISA;ARRUE RECONDO IMANOL. Disolución.Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1194 , F 55, S 8, H SS 3889, I/A 31 ( 2.11.17).

04 de Julio de 2017
Otros conceptos: Que de conformidad con el artículo 51.1 de la LME, con fecha 21 de junio de 2017, la sociedad ha publicado en supágina web corporativa "www.bellota.com" el proyecto común de fusión de las sociedades "VENANPRI XXI, S.L." como SOCIEDADABSORBENTE y "PAMECAL, S.A.", "MIRANDAOLA INVERSIONES Y GESTION, S.L." y "CORPORACION PATRICIO ECHEVERRIA,S.A." como. Datos registrales. T 1194 , F 55, S 8, H SS 3889, I/A30 Ma (28.06.17).

15 de Junio de 2017
Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.bellota.com. Datos registrales. T 1194 , F 55, S 8, H SS3889, I/A 30 (31.05.17).

25 de Abril de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ MAESO LORENZO;ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUEL ALBERTO. Datos registrales. T1194 , F 49, S 8, H SS 3889, I/A 29 (10.04.17).

18 de Abril de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MUÑOZ MURILLO YOLANDA. Apoderado: MUÑOZ MURILLO YOLANDA. Datos registrales. T 1194 ,F 49, S 8, H SS 3889, I/A 28 (30.03.17).

01 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ MURILLO YOLANDA. Datos registrales. T 1194 , F 49, S 8, H SS 3889, I/A 27 (14.07.16).

02 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MUÑOZ MURILLO YOLANDA;ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUEL ALBERTO;HERRANZGARCIA MARIA LUISA;ARRUE RECONDO IMANOL. Apoderado: GARRETTE STEVEN L. Datos registrales. T 1194 , F 48, S 8, HSS 3889, I/A 26 (20.08.15).

01 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: AROSTEGI LACABEX LAUREANO;2401302 ONTARIO INC;1800 BBSI INC. Secretario: ARANBURUURIBARRI ESTIBALIZ. VsecrNoConsj: SOLIS TELLO CANDELA. Vsecr2.NC: DE LA FUENTE MUGURUZA IGNACIO. Vicepresid.:AROSTEGI LACABEX LAUREANO. Presidente: 1800 BBSI INC. Nombramientos. Adm. Unico: VENANPRI XXI SL. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Otros conceptos:Modificación de los artículos 6º y 8º de los Estatutos sociales en cuanto al Organo de Administración. ADMINISTRADOR UNICO, porplazos de CINCO AÑOS. Datos registrales. T 1194 , F 48, S 8, H SS 3889, I/A 25 (23.06.15).

08 de Junio de 2015
Cambio de domicilio social. C/ UROLA 10 (LEGAZPI). Datos registrales. T 1194 , F 47, S 8, H SS 3889, I/A 23 (29.05.15).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: AGUIRRE POLO IRANTZU. Nombramientos. Secretario: ARANBURU URIBARRI ESTIBALIZ.

06 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MUÑOZ MURILLO YOLANDA;ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUEL ALBERTO;HERRANZGARCIA MARIA LUISA;OLIVER GIMENO RAFAEL. Datos registrales. T 1194 , F 46, S 8, H SS 3889, I/A 22 (23.03.15).

16 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MUÑOZ MURILLO YOLANDA. Apo.Manc.: ZUBIZARRETA LECUMBERRI MIGUELALBERTO;HERRANZ GARCIA MARIA LUISA;OLIVER GIMENO RAFAEL. Datos registrales. T 1194 , F 45, S 8, H SS 3889, I/A 21 (3.12.14).

09 de Julio de 2014
Fe de erratas: En el BORME nº97 de fecha 26/5/2014, se hizo constar erroneamente LA FECHA DE EFECTOS DEL CESE YNOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, siendo la CORRECTA el día 20 DE MARZO DE 2014.- Datos registrales. T 1194 , F 45, S 8,H SS 3889, I/A 20 (30.06.14).

26 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ECHEVERRIA ALCORTA MARIA;ECHEVERRIA ALCORTA INMACULADA;ECHEVERRIA ALCORTAMIGUEL IGNACIO;ECHEVERRIA ALCORTA PABLO;ECHEVERRIA ALCORTA PATRICIO. Secretario: ECHEVERRIA ALCORTAMARIA. Cons.Del.Sol: ECHEVERRIA ALCORTA MARIA;ECHEVERRIA ALCORTA INMACULADA. Presidente: ECHEVERRIAALCORTA MIGUEL IGNACIO. Cons.Del.Sol: ECHEVERRIA ALCORTA MIGUEL IGNACIO;ECHEVERRIA ALCORTAPABLO;ECHEVERRIA ALCORTA PATRICIO. Revocaciones. Apoderado: ECHEVERRIA AGUIRRE PATRICIO. Nombramientos.Consejero: AROSTEGI LACABEX LAUREANO;2401302 ONTARIO INC;1800 BBSI INC. Presidente: 1800 BBSI INC. Vicepresid.:AROSTEGI LACABEX LAUREANO. SecreNoConsj: AGUIRRE POLO IRANTZU. VsecrNoConsj: SOLIS TELLO CANDELA. Datos

Declaración de unipersonalidad. Socio único: VENANPRI XXI SL. Datos registrales. T 1194 , F 45, S 8, H SS 3889, I/A 19(16.05.14).

29 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: ECHEVERRIA ALCORTA PABLO. Nombramientos. Secretario: ECHEVERRIA ALCORTA MARIA.Datos registrales. T 1194 , F 40, S 8, H SS 3889, I/A 16 (23.08.13).

Ceses/Dimisiones. Presidente: ECHEVERRIA ALCORTA INMACULADA. Con.Delegado: ECHEVERRIA ALCORTA INMACULADA.Nombramientos. Presidente: ECHEVERRIA ALCORTA MIGUEL IGNACIO. Consejero: ECHEVERRIA ALCORTA PATRICIO.Cons.Del.Sol: ECHEVERRIA ALCORTA INMACULADA;ECHEVERRIA ALCORTA MARIA;ECHEVERRIA ALCORTAPATRICIO;ECHEVERRIA ALCORTA MIGUEL IGNACIO;ECHEVERRIA ALCORTA PABLO. Reelecciones. Consejero: ECHEVERRIAALCORTA INMACULADA;ECHEVERRIA ALCORTA MARIA;ECHEVERRIA ALCORTA MIGUEL IGNACIO;ECHEVERRIA ALCORTAPABLO. Secretario: ECHEVERRIA ALCORTA MARIA. Datos registrales. T 1194 , F 40, S 8, H SS 3889, I/A 17 (23.08.13).

30 de Agosto de 2010
Nombramientos. Secretario: ECHEVERRIA ALCORTA PABLO. Datos registrales. T 1194 , F 40, S 8, H SS 3889, I/A 15 (20.08.10).

26 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ECHEVERRIA ALCORTA PATRICIO. Secretario: ECHEVERRIA ALCORTA PATRICIO. Datosregistrales. T 1194 , F 39, S 8, H SS 3889, I/A 14 (17.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información