Buscador CIF Logo

Actos BORME Parc Eolic Lera Bella Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Parc Eolic Lera Bella Sl

Actos BORME Parc Eolic Lera Bella Sl - B63368609

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Parc Eolic Lera Bella Sl con CIF B63368609

馃敊 Perfil de Parc Eolic Lera Bella Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Parc Eolic Lera Bella Sl

16 de Marzo de 2021
Revocaciones. APOD.MANCOMU: RIBERA SOLER ANTONIO;MONSO SALAS JORDI. APODERAD.SOL: SANZ FEREENRIQUE;MARTIN TOBES CARMEN MARIA;DE EUSEBIO GOMEZ PEDRO IGNACIO. Datos registrales. T 46376 , F 171, S 8, H B296801, I/A 33 ( 8.03.21).

23 de Febrero de 2021
Revocaciones. ADM.UNICO: ALSTOM RENOVABLES ESPA脩A SL. REPR.143 RRM: PUIGCORBE PUNZANO JORDI.Nombramientos. ADM.UNICO: RIERA SAPERA JUAN. Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:EOLICAPUJALT S.L. Cambio de domicilio social. CL FRANCESC CASAJOANA Num.46 (CALAF). Datos registrales. T 46376 , F 171, S8, H B 296801, I/A 32 (12.02.21).

09 de Mayo de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: SANZ FERE ENRIQUE. Datos registrales. T 40721 , F 140, S 8, H B 296801, I/A 30 (27.04.18).

Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTIN TOBES CARMEN MARIA;DE EUSEBIO GOMEZ PEDRO IGNACIO. Datosregistrales. T 46376 , F 171, S 8, H B 296801, I/A 31 (27.04.18).

24 de Agosto de 2017
Revocaciones. REPR.143 RRM: URREA PEREZ FELIX. Nombramientos. REPR.143 RRM: PUIGCORBE PUNZANO JORDI.Datos registrales. T 40721 , F 140, S 8, H B 296801, I/A 27 (16.08.17).

Revocaciones. APODERAD.SOL: FELIX URREA PEREZ. Datos registrales. T 40721 , F 140, S 8, H B 296801, I/A 28 (16.08.17).

Revocaciones. APODERADO: CUEVAS DE MIGUEL JOSE CARLOS;ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER;VERDURA GOMEZDANIELAPODERAD.SOL: NAVAZO CUADRADO PABLO. APOD.MANCOMU: MEHDI JAMAL ALAOUI. Datos registrales. T 40721 ,F 140, S 8, H B 296801, I/A 29 (16.08.17).

07 de Abril de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: FELIX URREA PEREZ. Datos registrales. T 40721 , F 139, S 8, H B 296801, I/A 26 (30.03.17).

09 de Septiembre de 2016
Revocaciones. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER. Nombramientos. REPR.143 RRM: URREA PEREZFELIX. Datos registrales. T 40721 , F 139, S 8, H B 296801, I/A 25 ( 1.09.16).

29 de Enero de 2016
Modificaciones estatutarias. ART. 25 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DEENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 40721 , F 139, S 8, H B 296801, I/A 24(21.01.16).

07 de Octubre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 110.680,00 Euros. Resultante Suscrito: 159.690,00 Euros. Datos registrales. T 40721 , F 138, S 8,H B 296801, I/A 23 (30.09.15).

27 de Agosto de 2015
Revocaciones. APODERADO: I脩IGUEZ BLANCO JUAN MARIA. Datos registrales. T 40721 , F 138, S 8, H B 296801, I/A 22(19.08.15).

11 de Junio de 2015
Nombramientos. APOD.MANCOMU: RIBERA SOLER ANTONIO;MONSO SALAS JORDI;MEHDI JAMAL ALAOUI. Datosregistrales. T 40721 , F 137, S 8, H B 296801, I/A 21 ( 3.06.15).

12 de Febrero de 2015
Revocaciones. APOD.MANCOMU: HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL;GARCIA GARCIA MARIA. Datos registrales. T40721 , F 137, S 8, H B 296801, I/A 20 ( 4.02.15).

12 de Agosto de 2013
Revocaciones. ADM.UNICO: ALSTOM WIND SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER. Nombramientos.ADM.UNICO: ALSTOM RENOVABLES ESPA脩A SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER. Datos registrales.T 40721 , F 136, S 8, H B 296801, I/A 17 ( 1.08.13).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL;GARCIA GARCIA MARIA. APODERAD.SOL:NAVAZO CUADRADO PABLO. Datos registrales. T 40721 , F 136, S 8, H B 296801, I/A 18 ( 1.08.13).

Revocaciones. APODERADO: NICOLAS GALLOT. Datos registrales. T 40721 , F 137, S 8, H B 296801, I/A 19 ( 1.08.13).

23 de Diciembre de 2011
Nombramientos. APODERADO: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER. Datos registrales. T 40721 , F 135, S 8, H B 296801,I/A 15 (13.12.11).

Revocaciones. APODERADO: CARULLA CARTANYA FRANCESC;OLIVA RAMS ROSA MARIA;SANMARTI AMAT JOAN.Nombramientos. APODERADO: VERDURA GOMEZ DANIEL. Datos registrales. T 40721 , F 135, S 8, H B 296801, I/A 16(13.12.11).

25 de Noviembre de 2011
Revocaciones. REPR.143 RRM: SANMARTI AMAT JOAN. Nombramientos. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESCXAVIER. Datos registrales. T 40721 , F 134, S 8, H B 296801, I/A 14 (15.11.11).

20 de Mayo de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 36.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 49.010,00 Euros. Datos registrales. T 40721 , F 134, S 8, H B296801, I/A 13 ( 7.05.10).

17 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.010,00 Euros. Datos registrales. T 40721 , F 133, S 8, H B296801, I/A 12 ( 5.02.10).

14 de Enero de 2010
Nombramientos. ADM.UNICO: ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES SL. REPR.143 RRM: SANMARTI AMAT JOAN. Datosregistrales. T 40721 , F 133, S 8, H B 296801, I/A 11 (30.12.09).

14 de Mayo de 2009
Revocaciones. ADM.UNICO: ECOTECNIA INVERSIONES SL. REPR.143 RRM: SANMARTI AMAT JOAN. Datos registrales. T40721 , F 132, S 8, H B 296801, I/A 10 ( 6.05.09).

05 de Febrero de 2009
Revocaciones. REPR.143 RRM: CAMARA SERRANO JOAN MARIA. Nombramientos. REPR.143 RRM: SANMARTI AMAT JOAN.Datos registrales. T 40721 , F 132, S 8, H B 296801, I/A 9 (27.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n