Actos BORME de Parque Cientifico Y Tecnologico Cartuja Sa
30 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PAEZ VELEZ BRACHO FRANCISCO JAVIER. Vicepr.2: PAEZ VELEZ BRACHO FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 6738 , F 34, S 8, H SE 4139, I/A 133 ( 4.08.23).
25 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRO JIMENEZ ANTONIO MANUEL. Nombramientos. Consejero: GALLARDO GUTIERREZJOAQUIN. Datos registrales. T 6738 , F 34, S 8, H SE 4139, I/A 132 (18.05.23).
21 de Febrero de 2023Fe de erratas: Don Francisco Javier P谩ez V茅lez-Bracho es designado Vicepresidente Segundo del Consejo de Administraci贸n, Seg煤nresulta de la inscripci贸n 120陋.- Datos registrales. T 6715 , F 120, S 8, H SE 4139, I/A 120 (12.11.19).
26 de Enero de 2023Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 6738 , F 33, S 8, H SE 4139, I/A 131 (17.01.23).
12 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO;DEL CAMPO SANCHEZ MYRIAM;VELASCO PEREZROGELIO. Presidente: VELASCO PEREZ ROGELIO. Nombramientos. Consejero: GOMEZ VILLAMANDOS JOSECARLOS;VALENZUELA ROMERO MARIA NIEVES;CASTRO JIMENEZ ANTONIO MANUEL. Presidente: GOMEZ VILLAMANDOSJOSE CARLOS. Datos registrales. T 6715 , F 129, S 8, H SE 4139, I/A 129 (30.11.22).
Revocaciones. Apoderado: DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 6738 , F 33, S 8, H SE 4139, I/A 130(30.11.22).
26 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 6715 , F 128, S 8, H SE 4139, I/A 128(19.05.22).
19 de Abril de 2022Nombramientos. Consejero: DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO. Reelecciones. Consejero: EXCELENTISIMA DIPUTACIONPROVINCIAL DE SEVILLA. Otros conceptos: SE DESIGNA A DO脩A ASUNCION LLAMAS RENGEL COMO REPRESENTANTEPERSONA FISICA DE "EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE"PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CARTUJA, S.A.". Datos registrales. T 6715 , F 127, S 8, H SE 4139, I/A 127 ( 8.04.22).
03 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL VALLE CEBADA LORETO. Datos registrales. T 6715 , F 123, S 8, H SE 4139, I/A 125(23.02.22).
Modificaciones estatutarias. 1. Modificaci贸n parcial de los estatutos sociales.-. 1. Modificaci贸n parcial de los Estatutos Sociales.-.Art铆culo de los estatutos: 3. Objeto social.-. Cambio de objeto social. La Sociedad tendr谩 por objeto crear, sostener y gestionarmecanismos destinados a contribuir a la promoci贸n y desarrollo de las actividades vinculadas a la investigaci贸n, la tecnolog铆a, lainnovaci贸n, la internacionalizaci贸n y el desarrollo de la actividad econ贸mica de las entidades y empresas. Datos registrales. T 6715 ,F 123, S 8, H SE 4139, I/A 126 (23.02.22).
24 de Agosto de 2021Reelecciones. Consejero: UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Otros conceptos: Designado Don Miguel Angel Castro Arroyo, con DNI30.042.650-M, como representante persona f铆sica.- Datos registrales. T 6715 , F 122, S 8, H SE 4139, I/A 124 (12.08.21).
28 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: RIOS SANCHEZ ROSA MARIA. Vicepr.1: DEL VALLE CEBADA LORETO. Nombramientos.Consejero: VELASCO PEREZ ROGELIO. Presidente: VELASCO PEREZ ROGELIO. Consejero: CORTES ACHEDAD PABLO.Vicepr.1: CORTES ACHEDAD PABLO. Datos registrales. T 6715 , F 121, S 8, H SE 4139, I/A 123 (16.12.20).
16 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: OLIVAR CAYUELA NIEVES. Nombramientos. Consejero: CANDAU LANCHA RAFAEL. Datosregistrales. T 6715 , F 121, S 8, H SE 4139, I/A 121 ( 6.11.20).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTIGOSA BRUN MANUEL. Presidente: ORTIGOSA BRUN MANUEL. Revocaciones. Apoderado:ORTIGOSA BRUN MANUEL. Datos registrales. T 6715 , F 121, S 8, H SE 4139, I/A 122 ( 6.11.20).
20 de Noviembre de 2019Nombramientos. Consejero: PAEZ VELEZ BRACHO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 6715 , F 120, S 8, H SE 4139, I/A119 (12.11.19).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ASTORGA MORANO RICARDO. Nombramientos. Vicepr.1: DEL VALLE CEBADA LORETO.Secr.2: PAEZ VELEZ BRACHO FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: la Excelentisima Diputaci贸n Provincial de Sevilla , designacomo su representante persona fisica a Da Asunci贸n Llamas Rengel. Datos registrales. T 6715 , F 120, S 8, H SE 4139, I/A 120(12.11.19).
16 de Agosto de 2019Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CASTRE脩O LUCAS MARIA DEL CARMEN CLARISA. Vicepr.2:CASTRE脩O LUCAS MARIA DEL CARMEN CLARISA. Nombramientos. Consejero: OLIVAR CAYUELA NIEVES. Datos registrales.T 6715 , F 119, S 8, H SE 4139, I/A 118 ( 6.08.19).
13 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 6715 , F 119, S 8, H SE 4139, I/A 117 ( 5.08.19).
30 de Mayo de 2019Nombramientos. Presidente: ORTIGOSA BRUN MANUEL. Apoderado: ORTIGOSA BRUN MANUEL. Datos registrales. T 6406 , F138, S 8, H SE 4139, I/A 115 (20.05.19).
Nombramientos. Apo.D.Gral.: PEREZ DIAZ LUIS. Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: PEREZ DIAZ LUIS. Datos registrales. T6406 , F 14, S 8, H SE 4139, I/A 116 (20.05.19).
22 de Mayo de 2019Nombramientos. Consejero: DEL CAMPO SANCHEZ MYRIAM;DEL VALLE CEBADA LORETO;RIOS SANCHEZ ROSA MARIA.Otros conceptos: Fijar en ocho el n煤mero de integrantes del Consejo dentro de la actual horquilla estatutaria dejando constancia dela intenci贸n de cubrir, a la mayor brevedad posible, la vacante temporal que existe de un consejero. Datos registrales. T 6406 , F 138,S 8, H SE 4139, I/A 114 (15.05.19).
10 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: ALONSO MIRANDA AQUILINO. Consejero: ALONSO MIRANDA AQUILINO;GARCIA LEONMANUEL;CASTILLEJO CAICEO ROSA MARIA;CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 6406 , F 138, S 8,H SE 4139, I/A 113 (29.03.19).
25 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ DIAZ LUIS. Datos registrales. T 6406 , F 136, S 8, H SE 4139, I/A 111 (14.03.19).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: BLANCO GARCIA MARTIN G. Revocaciones. Apoderado: ALONSO MIRANDAAQUILINO;BLANCO GARCIA MARTIN G. Datos registrales. T 6406 , F 137, S 8, H SE 4139, I/A 112 (14.03.19).
10 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCIA LEON MANUEL. Revocaciones. Apoderado: GARCIA LEON MANUEL. Nombramientos.Presidente: ALONSO MIRANDA AQUILINO. Apoderado: ALONSO MIRANDA AQUILINO. Datos registrales. T 6406 , F 134, S 8, HSE 4139, I/A 109 ( 3.08.18).
Nombramientos. VsecrNoConsj: ASTORGA MORANO RICARDO. Datos registrales. T 6406 , F 136, S 8, H SE 4139, I/A 110 (3.08.18).
09 de Agosto de 2018Reelecciones. Consejero: CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 6406 , F 134, S 8, H SE 4139, I/A 108 (2.08.18).
18 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: UFANO RAMIREZ CONCEPCION. Nombramientos. Consejero: EXCELENTISIMA DIPUTACIONPROVINCIAL DE SEVILLA. Datos registrales. T 6406 , F 133, S 8, H SE 4139, I/A 107 (10.04.18).
16 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Dir. General: MENCIA MORALES FRANCISCO. Datos registrales. T 6406 , F 133, S 8, H SE 4139, I/A 106 (
16 de Noviembre de 2017Nombramientos. Consejero: ALONSO MIRANDA AQUILINO. Datos registrales. T 6406 , F 133, S 8, H SE 4139, I/A 105 ( 7.11.17).
25 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Dir. General: SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA. Revocaciones. Apo.Sol.: SAEZ CARRASCOSA MARIATERESA. Nombramientos. Dir. General: BLANCO GARCOA MARTON G. Apoderado: BLANCO GARCOA MARTON G. Datosregistrales. T 3715 , F 158, S 8, H SE 4139, I/A 103 (16.08.17).
Otros conceptos: En atenci贸n a lo establecido en el art铆culo 27潞 del nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales, se fija en 10 eln煤mero de integrantes del Consejo de Administraci贸n, que, se encuentra pendiente de cubrir 3 vacantes. Datos registrales. T 6406 ,F 132, S 8, H SE 4139, I/A 104 (16.08.17).
21 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: GARCIA LEON MANUEL. Datos registrales. T 3715 , F 157, S 8, H SE 4139, I/A 102 (10.08.17).
01 de Agosto de 2017Reelecciones. Consejero: UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Datos registrales. T 3715 , F 156, S 8, H SE 4139, I/A 101 (24.07.17).
27 de Diciembre de 2016P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.pctcartuja.es. Datos registrales. T 3715 , F 156, S 8, HSE 4139, I/A 99 (16.12.16).
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 3715 , F 156, S 8, H SE 4139, I/A 100 (16.12.16).