Actos BORME de Parque Empresarial De Mijas Sl
23 de Noviembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 296.591,30 Euros. Resultante Suscrito: 982.914,10 Euros. Datos registrales. T 5398, L 4305, F 79,S 8, H MA 86509, I/A 11 (14.11.16).
30 de Agosto de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.176.905,20 Euros. Resultante Suscrito: 686.322,80 Euros. Datos registrales. T 5398, L4305, F 79, S 8, H MA 86509, I/A 10 (22.08.16).
03 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: FERNANDEZ MOYA JOSE JULIO. Vicepresid.: BRAVO VILLALBA FRANCISCO JOSE. Secretario:GOMEZ MORENO CRISTOBAL JESUS. Consejero: FERNANDEZ MOYA JOSE JULIO;CARMONA GOMEZ JOSE MARIA.Con.Delegado: FERNANDEZ MARTINO JOSE ANGEL;GOMEZ MORENO CRISTOBAL JESUS;FERNANDEZ MOYA JOSEJULIO;GONZALEZ JAIME CRISTOBAL. Nombramientos. Presidente: BRAVO VILLALBA FRANCISCO JOSE. Vicepresid.: MARINLOPEZ MIGUEL ANGEL. Tesorero: GOMEZ MORENO CRISTOBAL JESUS;GONZALEZ JAIME CRISTOBAL. Secretario: ESTEBANCOLLADO FABIAN. Cons.Del.Man: BRAVO VILLALBA FRANCISCO JOSE;GOMEZ MORENO CRISTOBAL JESUS;GONZALEZJAIME CRISTOBAL;ESTEBAN COLLADO FABIAN. Datos registrales. T 5398, L 4305, F 78, S 8, H MA 86509, I/A 8 (24.07.15).
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: http://www.parqueempresarialmijas.com. Datos registrales. T5398, L 4305, F 79, S 8, H MA 86509, I/A 9 (24.07.15).
19 de Mayo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.829.642,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.863.228,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Convocatoria.-. Cambio de domicilio social. AVDA DE ANDALUCIA 3 - EDF. FORMACION Y EMPLEO, OF. (MIJAS). Cambio deobjeto social. 1.- Construcci贸n, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Distribuci贸n comercial.Importaci贸n y exportaci贸n. 3.- Actividades inmobiliarias. 5.- Industrias manufactureras y textiles. 6.- Turismo, hosteler铆a y restauraci贸n.7.- Prestaci贸n de servicios. Actividades de g. Datos registrales. T 4128, L 3039, F 157, S 8, H MA 86509, I/A 7 ( 8.05.15).
07 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO JESUS. Nombramientos. Consejero: ESTEBAN COLLADO FABIAN.Datos registrales. T 4128, L 3039, F 157, S 8, H MA 86509, I/A 6 (25.01.12).
27 de Septiembre de 2010Cambio de domicilio social. CMNO DE LAS CA脩ADAS - OFICINA 17, CENTRO DE NEGOC (MIJAS). Datos registrales. T 4128, L3039, F 157, S 8, H MA 86509, I/A 4 (13.09.10).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 177,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.586,00 Euros. Datos registrales. T 4128, L 3039, F157, S 8, H MA 86509, I/A 5 (13.09.10).
17 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO GORDON ANTONIO. Vicepresid.: ARROYO GORDON ANTONIO. Consejero: LOPEZPERAL JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: PARISI ALFONSO;CARMONA GOMEZ JOSE MARIA. Vicepresid.: BRAVOVILLALBA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 4128, L 3039, F 156, S 8, H MA 86509, I/A 2 ( 2.04.09).