Actos BORME de Parque Eolico Cerro Mingarron Sl
04 de Octubre de 2013Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1529 , F 191, S 8, H TO 33152, I/A 4 (26.09.13).
18 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ GOMEZ LUIS ANTONIO. Vicepresid.: MARTINEZ GOMEZ LUIS ANTONIO.Nombramientos. Consejero: NOFUENTES GARCIA GUSTAVO. Reelecciones. Consejero: RUBIO POLO VENANCIO. Presidente:RUBIO POLO VENANCIO. Consejero: RUIZ CASTELLANOS MARIA ELENA. Datos registrales. T 1529 , F 191, S 8, H TO 33152, I/A3 (10.06.13).
06 de Octubre de 2011Cambio de domicilio social. C/ BERNA 1 (TOLEDO). Datos registrales. T 1529 , F 191, S 8, H TO 33152, I/A 2 (26.09.11).
28 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: RENERGES SL. Representan: BERTOLA SORIANO ENRIQUE. Consejero: ABELLAN ESPARCIAJUAN MANUEL;SERRA PERIS MARIA MANUELA. Cons.Del.Man: ABELLAN ESPARCIA JUAN MANUEL;RUBIO POLO VENANCIO.Consejero: MATESANZ POSTIGO FERMIN. Nombramientos. SecreNoConsj: DEL VALLE CONDE JESUS MARIA. Apoderado:IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SL. Otros conceptos: SE MODIFICA EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS. Datosregistrales. T 25541 , F 198, S 8, H M 460255, I/A 4 (15.06.11).
18 de Febrero de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE ICAZA DE LA SOTA RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: ASTIZ BARRENECHEAUNAI;TARANCO ZABALA ENEKO;RIOPEREZ ORTA ALVARO;CANALES ABAITUA PABLO. Datos registrales. T 25541 , F 197, S8, H M 460255, I/A 3 ( 8.02.11).
14 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: LARRA脩AGA ARRUTI MARCELINO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: MATESANZPOSTIGO FERMIN. Datos registrales. T 25541 , F 197, S 8, H M 460255, I/A 2 ( 1.12.09).