Actos BORME de Parque Industrial La Rad Sociedad De Responsabilidad Limitada
27 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: TORREALBA ELIAS JOSE ANTONIO. Cons.Del.Man: TORREALBA ELIAS JOSEANTONIO;MARTINEZ HERNANDO JESUS ANTONIO;LEZA MARTINEZ JOSE RAMON. Nombramientos. Consejero: BEZARESMUNILLA ELADIO. Co.De.Ma.So: MARTINEZ HERNANDO JESUS ANTONIO;BEZARES MUNILLA ELADIO;LEZA MARTINEZ JOSERAMON. Datos registrales. T 603 , F 7, S 8, H LO 10258, I/A 12 (15.12.22).
25 de Enero de 2021Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL VILLANUEVA 5 2潞 - OFICINA 3 (LOGRO脩O). Datos registrales. T 603 , F 7, S 8, H LO10258, I/A 11 (15.01.21).
30 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Secretario: GOMEZ AGUILAR JOSE MARIA. Nombramientos. Secretario: MARTINEZ HERNANDO JESUSANTONIO. Datos registrales. T 603 , F 7, S 8, H LO 10258, I/A 10 (21.01.20).
06 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: TORREALBA ELIAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 603 , F 7, S 8, H LO 10258, I/A 9(24.02.17).
09 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CERECEDA SAENZ ANGELA ELENA. Datos registrales. T 603 , F 6, S 8, H LO 10258, I/A 8 (1.06.15).
18 de Agosto de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 41.625,00 Euros. Resultante Suscrito: 235.875,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:967.550,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.203.425,00 Euros. Datos registrales. T 603 , F 6, S 8, H LO 10258, I/A 7 ( 4.08.14).
30 de Junio de 2014Nombramientos. Consejero: CERECEDA SAENZ ANGELA ELENA. Datos registrales. T 603 , F 6, S 8, H LO 10258, I/A 6(18.06.14).
08 de Enero de 2014Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ ARGIZ MANUEL RAMON. Cambio de domicilio social. AVDA PORTUGAL 2 3潞 IZ(LOGRO脩O). Datos registrales. T 603 , F 5, S 8, H LO 10258, I/A 5 (24.12.13).
14 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ABDALLAH MAHMUD IBRAHIM AHMAD;URIZ UBIS JESUS. Datos registrales. T 603 , F 4, S 8, HLO 10258, I/A 4 ( 4.01.13).