Buscador CIF Logo

Actos BORME Parque Tecnologico Walqa Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Parque Tecnologico Walqa Sa

Actos BORME Parque Tecnologico Walqa Sa - A22266217

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Huesca para Parque Tecnologico Walqa Sa con CIF A22266217

馃敊 Perfil de Parque Tecnologico Walqa Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Huesca

Actos BORME de Parque Tecnologico Walqa Sa

11 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: AYUNTAMIENTO DE HUESCA. Vicepresid.: AYUNTAMIENTO DE HUESCA. Consejero: ALIAGALOPEZ ARTURO;MOLINERO GARCIA MARIA PILAR;ESTAUN GARCIA LUIS-SEBASTIAN;LOPEZ CABEZA JESUS;CADENAMONLLOR JOSE LUIS. Presidente: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Consejero: GERBAS ARAGUES ROSA;ARTIEDA PUYALESTER;OROS CONSTANTE ROBERTO. Nombramientos. Consejero: VAQUERO PERIANEZ MARIA DEL MAR;PA脩OS DEARRIBA MARIA DEL MAR;ASENSIO GRIJALBA CRISTINA;BORAO MOROS ESTHER;BARQUERO SOLANES IGNACIO;ORDUNAPONS LORENA;ALMUDEVAR ZAMORA BELEN;MAGAN FONCILLAS SUSANA;SOLER NAVARRO MONICA. Presidente: VAQUEROPERIANEZ MARIA DEL MAR. Vicepresid.: ORDUNA PONS LORENA. Apo.Man.Soli: ORTAS MARTIN CARLOS. D. Gerente: ORTASMARTIN CARLOS. Datos registrales. T 644 , F 171, S 8, H HU 6780, I/A 38 (30.11.23).

04 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: VAQUERO PERIANEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 644 , F 170, S 8, H HU 6780, I/A 37(27.11.23).

Revocaciones. Apo.Manc.: CORREAS USON LUIS CARLOS. Fe de erratas: Se RECTIFICA la publicaci贸n de la inscripci贸n 36陋donde 煤nicamente se p煤blico la REVOCACION como Apoderado Solidario de don LUIS CORREAS USON, siendo REVOCADOtambi茅n como Apoderado Mancomunado. Datos registrales. T 644 , F 170, S 8, H HU 6780, I/A 36 R (27.11.23).

28 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: CORREAS USON LUIS CARLOS. Revocaciones. Apo.Sol.: CORREAS USON LUIS CARLOS.Datos registrales. T 644 , F 170, S 8, H HU 6780, I/A 36 (21.08.23).

04 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: LORENTE PASTOR BEATRIZ. Apo.Sol.: LORENTE PASTOR BEATRIZ. Nombramientos. Apo.Sol.:GALLEGO COLLADO ANTONIO. Apo.Manc.: GALLEGO COLLADO ANTONIO. Apo.Sol.: CARRERO SESE PAZ. Datos registrales.T 644 , F 169, S 8, H HU 6780, I/A 35 (29.03.23).

14 de Marzo de 2022
Nombramientos. VsecrNoConsj: AGUERAS ANGULO ISABEL. Datos registrales. T 644 , F 169, S 8, H HU 6780, I/A 33 ( 7.03.22).

Reelecciones. Aud.Manc: CGM AUDITORES SL;VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 644 , F 169, S 8, HHU 6780, I/A 34 ( 7.03.22).

08 de Marzo de 2022
Fe de erratas: En la inscripci贸n 26陋 la fecha de duraci贸n del cargo de do帽a Ester Artieda Puyal correcto es el 10/03/2024. Datosregistrales. T 644 , F 167, S 8, H HU 6780, I/A 26 (30.11.20).

09 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Consejero: GERBAS ARAGUES ROSA;ARTIEDA PUYAL ESTER. Datos registrales. T 644 , F 167, S 8, H HU6780, I/A 26 (30.11.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PALACIN CASTRO GUILLERMO. Nombramientos. Consejero: OROS CONSTANTE ROBERTO.Datos registrales. T 644 , F 167, S 8, H HU 6780, I/A 27 (30.11.20).

Reelecciones. Consejero: CAJA RURAL DE ARAGON SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI. Datos registrales. T 644 , F 167, S8, H HU 6780, I/A 28 (30.11.20).

Nombramientos. D. Gerente: CORREAS USON LUIS CARLOS. Apo.Sol.: CORREAS USON LUIS CARLOS. Apo.Manc.: CORREASUSON LUIS CARLOS. Datos registrales. T 644 , F 168, S 8, H HU 6780, I/A 29 (30.11.20).

Otros conceptos: Inclusi贸n de dos nuevos art铆culos con la numeraci贸n 30 bis y 30 ter. Datos registrales. T 644 , F 168, S 8, H HU6780, I/A 30 (30.11.20).

Reelecciones. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SL;CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 644 , F 169, S 8, HHU 6780, I/A 31 (30.11.20).

19 de Octubre de 2020
Fe de erratas: En la inscripci贸n 25陋 el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros fue por plazo de CUATRO A脩OS y nocomo por error se mand贸 publicar por cinco a帽os. Datos registrales. T 644 , F 166, S 8, H HU 6780, I/A 25 (20.01.20).

27 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GASTON MENAL MARTA;TEJEDOR SANZ RAMON;BELTRAN BLAZQUEZ FERNANDOANGEL;LANASPA SANTOLARIA LUIS;ROMERO HUESO MARIA DEL CARMEN. Presidente: GASTON MENAL MARTA. Consejero:ROMAY CARRACEDO ALFONSO;GALLEGO ARNAL FERNANDO. Revocaciones. Apo.Sol.: GASTON MENAL MARTA. Apo.Manc.:GASTON MENAL MARTA;GASTON MENAL MARTA. Apo.Sol.: GARCIA ANZANO CELIA. Apo.Manc.: GARCIA ANZANOCELIA;GASTON MENAL MARTA. Nombramientos. Apoderado: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Apo.Sol.: MOLINERO GARCIA MARIAPILAR. Apo.Manc.: MOLINERO GARCIA MARIA PILAR. Consejero: ALIAGA LOPEZ ARTURO;MOLINERO GARCIA MARIA

20 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: LORENTE PASTOR BEATRIZ. Apo.Manc.: LORENTE PASTOR BEATRIZ. Datos registrales. T 644 , F165, S 8, H HU 6780, I/A 24 (10.05.19).

25 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOVALES ESTALLO PILAR. Nombramientos. Consejero: GALLEGO ARNAL FERNANDO. Datosregistrales. T 644 , F 165, S 8, H HU 6780, I/A 23 (18.02.19).

27 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: SESE GRACIA BIENVENIDO. Datos registrales. T 644 , F 165, S 8, H HU 6780, I/A 22 (20.06.18).

18 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Apo.Manc.: DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Apoderado: DE LAHERA PASCUAL CRISTINA. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ANZANO CELIA. Apo.Manc.: GARCIA ANZANO CELIA;GASTONMENAL MARTA. Datos registrales. T 598 , F 49, S 8, H HU 6780, I/A 21 (10.05.18).

26 de Marzo de 2018
Nombramientos. Aud.Manc: CGM AUDITORES SL;VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 598 , F 49, S 8,H HU 6780, I/A 19 (19.03.18).

16 de Febrero de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 421.286,66 Euros. Resultante Suscrito: 1.306.387,34 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 799.985,06 Euros. Desembolsado: 799.985,06 Euros. Resultante Suscrito: 2.106.372,40 Euros. Resultante Desembolsado:2.106.372,40 Euros. Datos registrales. T 598 , F 48, S 8, H HU 6780, I/A 18 ( 9.02.17).

05 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Apo.Sol.: DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Nombramientos.Apoderado: DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Apo.Sol.: DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Apo.Manc.: DE LA HERA PASCUALCRISTINA;GASTON MENAL MARTA. Datos registrales. T 598 , F 48, S 8, H HU 6780, I/A 17 (29.11.16).

04 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENTE PALOMAR ELENA. Nombramientos. Consejero: SESE GRACIA BIENVENIDO;ROMAYCARRACEDO ALFONSO. Reelecciones. Consejero: AYUNTAMIENTO DE HUESCA. Vicepresid.: AYUNTAMIENTO DE HUESCA.Consejero: CAJA RURAL DE ARAGON SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI. Datos registrales. T 598 , F 47, S 8, H HU 6780, I/A16 (27.10.16).

01 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALIAGA LOPEZ ARTURO;NAVARRO ESPADA JAVIER;DOMINGO COMECHE SALVADOR;GASIONAGUILAR ANTONIO;IRZO BUENO LUIS ANTONIO;ACIN VIU ANA MARIA;LAFUENTE ASO FERNANDO;SABES TURMO SABESFERNANDO. Presidente: ALIAGA LOPEZ ARTURO. SecreNoConsj: ROMERO AZNAR ANA ELENA. Revocaciones. Apo.Sol.:ALIAGA LOPEZ ARTURO. Apo.Manc.: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Apo.Sol.: LOPEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: LOPEZSANCHEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: GASTON MENAL MARTA;TEJEDOR SANZ RAMON;BELTRANBLAZQUEZ FERNANDO ANGEL;LANASPA SANTOLARIA LUIS;NOVALES ESTALLO PILAR;ROMERO HUESO MARIA DELCARMEN;PALACIN CASTRO GUILLERMO. Presidente: GASTON MENAL MARTA. Apo.Sol.: GASTON MENAL MARTA. Apo.Manc.:GASTON MENAL MARTA. SecreNoConsj: BASELGA LORENTE SANDRA. Apo.Sol.: DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Apo.Manc.:DE LA HERA PASCUAL CRISTINA. Datos registrales. T 598 , F 46, S 8, H HU 6780, I/A 15 (25.01.16).

24 de Diciembre de 2014
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 900.765,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.186.017,00Euros. Resultante Suscrito: 604.643,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.123.031,00 Euros. Desembolsado: 1.123.031,00Euros. Resultante Suscrito: 1.727.674,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.727.674,00 Euros. P谩gina web de la sociedad.Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.ptwalqa.com. Datos registrales. T 598 , F 44, S 8, H HU 6780, I/A 14 (18.12.14).

Ceses/Dimisiones. Secretario: LIDON TORRIJO PILAR. Nombramientos. SecreNoConsj: ROMERO AZNAR ANA ELENA. Datosregistrales. T 598 , F 44, S 8, H HU 6780, I/A 13 (18.12.14).

23 de Septiembre de 2014
Otros conceptos: Designaci贸n de la persona f铆sica representante del Consejero Caja rural de Arag贸n, Sociedad Cooperativa deCredito, en la persona de don Marcos Antonio Puyalto Lucindo. Cambio de denominaci贸n del Consejero, la Sociedad Nueva Caja Ruralde Arag贸n, SCC, por la de "CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP. DE CREDITO. Datos registrales. T 598 , F 44, S 8, H HU 6780, I/A12 (17.09.14).

11 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PASAMAR BELENGUER SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: VICENTE PALOMAR ELENA.Datos registrales. T 598 , F 44, S 8, H HU 6780, I/A 11 ( 4.08.14).

07 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: LATORRE MARTINEZ JOSE LUIS. Apo.Sol.: LATORRE MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos.Apo.Sol.: LOPEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: LOPEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 463, L 140, F220, S 8, H HU 6780, I/A 10 (30.01.13).

21 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALIAGA LOPEZ ARTURO;AYUNTAMIENTO DE HUESCA;CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOSPIRINEOS S. COOP. DE;PASAMAR BELENGUER SANTIAGO;GASION AGUILAR ANTONIO;CALVO RAPUN ALVARO;RUSPIRAMORRAJA ANTONIO;FELIPE SERRATE LUIS ELISEO. Presidente: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Vicepresid.: AYUNTAMIENTO DEHUESCA. Consejero: GARCIA MONGAY FERNANDO;LAFUENTE ASO FERNANDO;VENTURA CONTRERAS MARIA PILARGUADALUPE. Secretario: ARILLA LEZA JAVIER. Nombramientos. Consejero: ALIAGA LOPEZ ARTURO;AYUNTAMIENTO DEHUESCA;GASION AGUILAR ANTONIO;PASAMAR BELENGUER SANTIAGO;IRZO BUENO LUIS ANTONIO;DOMINGO COMECHESALVADOR;LAFUENTE ASO FERNANDO;ACIN VIU ANA MARIA;SABES TURMO SABES FERNANDO;NUEVA CAJA RURAL DEARAGON SOCIEDAD COOPERATIVA DE;NAVARRO ESPADA JAVIER. Presidente: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Vicepresid.:AYUNTAMIENTO DE HUESCA. Secretario: LIDON TORRIJO PILAR. Vicesecret.: PARRA LUIS RICARDO. Datos registrales. T 463,L 140, F 220, S 8, H HU 6780, I/A 9 (13.12.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n