Actos BORME de Parquing Santo Domingo Ii Sl
17 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: YAGUE MONTON JOSE MARIA;PIQUERO PASCUAL JESUS. Datos registrales. T 3949 , F 200, S 8,H Z 7095, I/A 24 (10.03.22).
10 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: PIQUERO PASCUAL JESUS. Datos registrales. T 3949 , F 199, S 8, H Z 7095, I/A 22 ( 3.08.21).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo decimonoveno. Remuneraci贸n del cargo de Administrador. El cargo de Administrador esgratuito. El Administrador de la sociedad podr谩 realizar trabajos dependientes de car谩cter laboral a favor de la empresa. En este caso,la retribuci贸n por los trabajos dependientes que realice y que deber谩n. Datos registrales. T 3949 , F 200, S 8, H Z 7095, I/A 23 (3.08.21).
04 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERO GUTIERREZ JESUS. Presidente: PIQUERO GUTIERREZ JESUS. Secretario: PIQUEROMARTINEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Presidente: PIQUERO MARTINEZ JOSE MARIA. Secretario: PIQUERO PASCUALMONTSERRAT. Datos registrales. T 3949 , F 198, S 8, H Z 7095, I/A 21 (28.07.20).
18 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: YAGUE MONTON JOSE MARIA. Datos registrales. T 3949 , F 197, S 8, H Z 7095, I/A 20 (11.04.18).
29 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERO GUTIERREZ JOSE MARIA. Secretario: PIQUERO GUTIERREZ JOSE MARIA.Nombramientos. Secretario: PIQUERO MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3949 , F 197, S 8, H Z 7095, I/A 19(21.07.14).
29 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 432.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 967.009,00 Euros. Cambio de objeto social. La explotaci贸n
26 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT. Datos registrales. T 2718 , F 129, S 8, H Z 7095, I/A 16(16.04.12).
Revocaciones. Apoderado: LUZ LASARTE ALVARO. Datos registrales. T 2718 , F 129, S 8, H Z 7095, I/A 17 (16.04.12).