Actos BORME de Partner Line Sa
21 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HERNANDEZ LORENZO RAMON JOSE;SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO.Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 4.DOMICILIO SOCIAL, NACIONALIDAD, WEB CORPORATIVA. ARTICULO 10. ORGANOS SOCIALES. ARTICULO 12.CONVOCATORIA DE LA JUNTA. ARTICULO 14. ASISTENCIA Y REPRESENTACION. ARTICULO 16. ACTA DE LA JUNTA.ARTICULO 17. ORGANO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 18. REPRESENTACION SOCIAL. ARTICULO 22. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de lap谩gina web corporativa: www.anuncioslegales.es/partnerline. Datos registrales. T 31531 , F 77, S 8, H M 11341, I/A 38 (14.02.23).
30 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALVAREZ REBECA. Datos registrales. T 31531 , F 76, S 8, H M 11341, I/A 37 (23.06.22).
15 de Marzo de 2022Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 14/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 23/01/2019. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID. Juez: JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ.Resoluciones: Aprobaci贸n del convenio. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 14/2015. Fecha de resoluci贸n 16/04/2015.Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 7 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON SANTIAGOSENENT MARTINEZ. Administrador Concursal. Fecha 23/01/2019, NIF/CIF 72475944T. PE脩A AIZPURUA VICTOR. Datosregistrales. T 31531 , F 75, S 8, H M 11341, I/A 34 ( 2.03.22).
11 de Marzo de 2022Reelecciones. Auditor: QUORUM AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Adm. Solid.: HERNANDEZ LORENZO RAMONJOSE;SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO. Datos registrales. T 31531 , F 76, S 8, H M 11341, I/A 36 ( 4.03.22).
09 de Marzo de 2022Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 14/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 28/10/2021. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID. Juez: JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ.Resoluciones: Se aprueba judicialmente la propuesta de modificaci贸n del convenio. Datos registrales. T 31531 , F 76, S 8, H M11341, I/A 35 ( 2.03.22).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Auditor: QUORUM AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 31531 , F 75, S 8, H M 11341, I/A33 (21.03.19).
19 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: CUBERO FERRADAL PABLO LUIS;SANTANA NAVARRO RAQUEL. Datos registrales. T 31531 , F 75,S 8, H M 11341, I/A 32 (11.01.17).
16 de Marzo de 2016Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ PACHECO CARMEN. Datos registrales. T 31531 , F 75, S 8, H M 11341, I/A 31 ( 7.03.16).
02 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HERNANDEZ LORENZO RAMON JOSE;SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO.Nombramientos. Auditor: QUORUM AUDITORES SLP. Adm. Solid.: HERNANDEZ LORENZO RAMON JOSE;SANCHEZ ANDRESGUILLERMO ALFONSO. Datos registrales. T 31531 , F 74, S 8, H M 11341, I/A 30 (23.02.16).
22 de Julio de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 14/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 16/04/2015. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 7 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ.Resoluciones: Se hace constar que el auto de declaraci贸n de concurso de fecha 16 de abril de 2015, ha quedado firme, quedandoconvertida la anotaci贸n preventiva A. que motiv贸 el mismo en inscripci贸n. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 14/2015.Fecha de resoluci贸n 16/04/2015. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 7 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID.Juez: DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ. Administrador Concursal. Fecha 16/04/2015, NIF/CIF 72475944T. PE脩A AIZPURUAVICTOR. Datos registrales. T 31531 , F 74, S 8, H M 11341, I/A 29 (14.07.15).
19 de Mayo de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 14/2015. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 16/04/2015. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 7 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ.Resoluciones: Las facultades legalmente previstas debera prestar su autorizacion o conformidad a los actos de administracion ydisposicion sobre el patrimonio del deudor realice este, en los terminos del Art.40 LC. Datos registrales. T 31531 , F 73, S 8, H M11341, I/A A ( 5.05.15).
17 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PACHECO CARMEN. Datos registrales. T 21800 , F 74, S 8, H M 11341, I/A 28 ( 9.01.14).
27 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: AUDITORES DEL OESTE SL. Datos registrales. T 21800 , F 74, S 8, H M 11341, I/A 27 ( 5.08.13).
11 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: SANTANA NAVARRO RAQUEL. Datos registrales. T 21800 , F 73, S 8, H M 11341, I/A 26 (30.08.12).
03 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: SOTO DIAZ LUIS. Datos registrales. T 21800 , F 73, S 8, H M 11341, I/A 25 (25.07.12).
14 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ANDRES SATURNINO EMILIO. Datos registrales. T 21800 , F 72, S 8, H M 11341, I/A 24(27.04.12).
24 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: BLAZQUEZ JIMENEZ AGUSTIN;LAGUNA VALDERRAMA JOSE MARIA. Datos registrales. T 21800 , F71, S 8, H M 11341, I/A 22 (11.05.11).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ DIEGO. Datos registrales. T 21800 , F 71, S 8, H M 11341, I/A 23 (11.05.11).
26 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ ANDRES SATURNINO;CUBERO FERRADAL PABLO LUIS. Datos registrales. T 21800 , F67, S 8, H M 11341, I/A 17 (17.11.10).
Nombramientos. Apoderado: CUBERO FERRADAL PABLO LUIS. Datos registrales. T 21800 , F 67, S 8, H M 11341, I/A 18(17.11.10).
Nombramientos. Apoderado: BLAZQUEZ JIMENEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 21800 , F 68, S 8, H M 11341, I/A 19(17.11.10).
Nombramientos. Apoderado: LAGUNA VALDERRAMA JOSE MARIA. Datos registrales. T 21800 , F 69, S 8, H M 11341, I/A 20(17.11.10).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ANDRES SATURNINO EMILIO;SOTO DIAZ LUIS. Datos registrales. T 21800 , F 71, S 8,H M 11341, I/A 21 (17.11.10).
24 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO;HERNANDEZ LORENZO RAMON JOSE;SANCHEZANDRES SATURNINO. Presidente: SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO. Secretario: HERNANDEZ LORENZO RAMONJOSE. Cons.Del.Sol: SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO;HERNANDEZ LORENZO RAMON JOSE. Nombramientos. Adm.Solid.: HERNANDEZ LORENZO RAMON JOSE;SANCHEZ ANDRES GUILLERMO ALFONSO. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Otros conceptos: SE MODIFICAN YREFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Datos registrales. T 21800 , F 65, S 8, H M 11341, I/A 16 (12.05.10).