Buscador CIF Logo

Actos BORME Pasapesca Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pasapesca Sa

Actos BORME Pasapesca Sa - A08373102

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Pasapesca Sa con CIF A08373102

馃敊 Perfil de Pasapesca Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Pasapesca Sa

09 de Mayo de 2023
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ACAUDIT AUDITORES SL. Datos registrales. T 46495 , F 3, S 8, H B 44516, I/A 69 (28.04.23).

25 de Marzo de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TARRES SINFREU FRANCISCO. AUDITOR SUP.: ACAUDIT AUDITORES SL. Datosregistrales. T 46495 , F 3, S 8, H B 44516, I/A 68 (16.03.21).

22 de Diciembre de 2020
Revocaciones. CONSEJERO: PAUNER CORBETO RAFAEL;PAUNER CORBETO FERRAN;PAUNER CORBETO MARCO.PRESIDENTE: PAUNER CORBETO MARCO. CONS. DELEG.: PAUNER CORBETO MARCO. CONSEJERO: VAZQUEZ ARIAS JOSELUIS. SECRETARIO: VAZQUEZ ARIAS JOSE LUIS. Nombramientos. ADM.UNICO: PAUNER CORBETO MARC. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7,8,10,18,21,22,23,24,26,31 Y 32 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIODE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 46495 , F 2, S 8, H B 44516, I/A 67 (14.12.20).

10 de Abril de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TARRES SINFREU FRANCISCO. AUDITOR SUP.: ACAUDIT AUDITORES SL. Datosregistrales. T 46495 , F 1, S 8, H B 44516, I/A 66 (29.03.19).

23 de Julio de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: BASAGA脩A BLADE LUIS. Datos registrales. T 38887 , F 200, S 8, H B 44516, I/A 64(13.07.18).

Revocaciones. APODERAD.SOL: PASCUAL MARTIN JOSE LUIS. Datos registrales. T 46495 , F 1, S 8, H B 44516, I/A 65(13.07.18).

17 de Noviembre de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: PASCUAL MARTIN JOSE LUIS. Datos registrales. T 38887 , F 200, S 8, H B 44516, I/A 63 (6.11.17).

01 de Julio de 2016
Cambio de domicilio social. PG PRATENSE,CALLE 111,S/N (PRAT DE LLOBREGAT (EL)). Datos registrales. T 38887 , F 200, S8, H B 44516, I/A 62 (21.06.16).

08 de Julio de 2015
Nombramientos. CONSEJERO: PAUNER CORBETO RAFAEL;PAUNER CORBETO FERRAN;PAUNER CORBETO MARCO.PRESIDENTE: PAUNER CORBETO MARCO. CONS. DELEG.: PAUNER CORBETO MARCO. CONSEJERO: VAZQUEZ ARIAS JOSELUIS. SECRETARIO: VAZQUEZ ARIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 38887 , F 199, S 8, H B 44516, I/A 61 (30.06.15).

07 de Mayo de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: PAUNER HERRERO RAFAEL. Datos registrales. T 38887 , F 199, S 8, H B 44516, I/A 60(28.04.15).

23 de Agosto de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: PAUNER HERRERO RAFAEL. PRESIDENTE: PAUNER HERRERO RAFAEL. CONS. DELEG.:PAUNER HERRERO RAFAEL. Nombramientos. PRESIDENTE: PAUNER CORBETO MARC. Datos registrales. T 38887 , F 198,S 8, H B 44516, I/A 59 (16.08.13).

22 de Febrero de 2012
Revocaciones. APODERADO: VAZQUEZ ARIAS JOSE LUIS;COT COLL VICTOR;MARTINEZ MOLINA PASCUAL. Datosregistrales. T 38887 , F 198, S 8, H B 44516, I/A 58 (10.02.12).

29 de Diciembre de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AYFRET ICE SL. Datos registrales. T 38887 , F 196, S 8, H B 44516, I/A 57

12 de Septiembre de 2011
Nombramientos. APODERADO: PAUNER CORBETO FERRAN. Datos registrales. T 38887 , F 195, S 8, H B 44516, I/A 56(30.08.11).

14 de Junio de 2010
Revocaciones. SECR.NO CONS: PAUNER CORBETO RAFAEL. Nombramientos. CONSEJERO: PAUNER HERRERO RAFAEL.PRESIDENTE: PAUNER HERRERO RAFAEL. CONS. DELEG.: PAUNER HERRERO RAFAEL. CONSEJERO: PAUNER CORBETORAFAEL;PAUNER CORBETO FERRAN;PAUNER CORBETO MARCO. CONS. DELEG.: PAUNER CORBETO MARCO.CONSEJERO: VAZQUEZ ARIAS JOSE LUIS. SECRETARIO: VAZQUEZ ARIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 38887 , F 194, S 8,H B 44516, I/A 55 (31.05.10).

30 de Diciembre de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 323.518,30 Euros. Resultante Suscrito: 615.544,20 Euros. Datos registrales. T 38887 , F194, S 8, H B 44516, I/A 54 (18.12.09).

01 de Diciembre de 2009
Modificaciones estatutarias. ART.23.-DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DEADMINISTRADOR.ART.24.-CONVOCATORIA Y QUORUM DE LAS REUNIONESDEL CONSEJO,ADOPCION DEACUERDOS,ACTAS Y CERTIFICACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 38887 , F 192, S 8, H B44516, I/A 53 (18.11.09).

25 de Agosto de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TARRES SINFREU FRANCISCO. AUDITOR SUP.: JOSEP PONSA VILALTA. Datos registrales.T 38887 , F 192, S 8, H B 44516, I/A 52 (13.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n