Buscador CIF Logo

Actos BORME Pascual Andina Holdings Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pascual Andina Holdings Sa

Actos BORME Pascual Andina Holdings Sa - A86031762

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Pascual Andina Holdings Sa con CIF A86031762

馃敊 Perfil de Pascual Andina Holdings Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Pascual Andina Holdings Sa

16 de Septiembre de 2016
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 10, LA REELECCION COMO CONSEJERO DE TOMASFLORENCIO PASCUAL GOMEZ-CUETARA, Y SE OMITIO EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE FELIX EDUARDOGASTON ALCALA. Datos registrales. T 28146 , F 34, S 8, H M 507033, I/A 10 (22.09.15).

Nombramientos. Consejero: GASTON ALCALA FELIX EDUARDO. Datos registrales. T 28146 , F 34, S 8, H M 507033, I/A 10(22.09.15).

01 de Octubre de 2015
Reelecciones. Consejero: PASCUAL GOMEZ-CUETARA TOMAS FLORENCIO;MENDOZA GIMENEZ LORENZO;BARAYBARCARDINI PABLO;SUCRE MATOS RAFAEL;LARRAZABAL AGUERREVERE MANUEL;BOLINAGA HERNANDEZ GUILLERMO.Presidente: MENDOZA GIMENEZ LORENZO. Vicepresid.: BARAYBAR CARDINI PABLO. Secretario: BOLINAGA HERNANDEZGUILLERMO. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Cambiode denominaci贸n social. MIGURT ANDINA HOLDINGS SA. Datos registrales. T 28146 , F 34, S 8, H M 507033, I/A 10 (22.09.15).

23 de Septiembre de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: POBA FOODS HOLDINGS SL. Datos registrales. T 28146 , F 34, S 8, H M 507033,I/A 9 (15.09.15).

02 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MELENDEZ GARCIA TOMAS JOSE;COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 28146 , F 34, S 8, H M 507033, I/A 8 (23.05.14).

23 de Julio de 2013
Reelecciones. Consejero: PASCUAL GOMEZ-CUETARA TOMAS FLORENCIO;MELENDEZ GARCIA TOMAS JOSE;COLOMINAPEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER;MENDOZA GIMENEZ LORENZO;BARAYBAR CARDINI PABLO;SUCRE MATOSRAFAEL;LARRAZABAL AGUERREVERE MANUEL;BOLINAGA HERNANDEZ GUILLERMO. Presidente: MENDOZA GIMENEZLORENZO. Vicepresid.: BARAYBAR CARDINI PABLO. Secretario: BOLINAGA HERNANDEZ GUILLERMO. Datos registrales. T28146 , F 33, S 8, H M 507033, I/A 7 (16.07.13).

24 de Febrero de 2012
Cambio de domicilio social. C/ AVENIDA DE FELIPE II 17 - 1潞 PISO, 1& OFICINA (MADRID). Datos registrales. T 28146 , F 33, S8, H M 507033, I/A 6 (14.02.12).

15 de Febrero de 2012
Reelecciones. Consejero: PASCUAL GOMEZ-CUETARA TOMAS FLORENCIO;MELENDEZ GARCIA TOMAS JOSE;COLOMINAPEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER;MENDOZA GIMENEZ LORENZO;BARAYBAR CARDINI PABLO;SUCRE MATOSRAFAEL;LARRAZABAL AGUERREVERE MANUEL;BOLINAGA HERNANDEZ GUILLERMO. Presidente: MENDOZA GIMENEZLORENZO. Secretario: BOLINAGA HERNANDEZ GUILLERMO. Vicepresid.: BARAYBAR CARDINI PABLO. Datos registrales. T28146 , F 33, S 8, H M 507033, I/A 5 ( 2.02.12).

08 de Marzo de 2011
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9.SE MODIFICA EL ARTICULO 3潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Datos registrales. T 28146 , F 32, S 8, H M 507033, I/A 4 (24.02.11).

21 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: LARRAZABAL AGUERREVERE MANUEL. Nombramientos. Vicepresid.: BARAYBAR CARDINIPABLO. Datos registrales. T 28146 , F 32, S 8, H M 507033, I/A 3 (10.02.11).

20 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: CABANAS NAVAZO BLANCA PILAR. Adm. Unico: IC NON RESIDENTS SL. Nombramientos.Consejero: PASCUAL GOMEZ-CUETARA TOMAS FLORENCIO;MELENDEZ GARCIA TOMAS JOSE;COLOMINA PEREZ DEL RIOFRANCISCO JAVIER;MENDOZA GIMENEZ LORENZO;BARAYBAR CARDINI PABLO;SUCRE MATOS RAFAEL;LARRAZABALAGUERREVERE MANUEL;BOLINAGA HERNANDEZ GUILLERMO. Presidente: MENDOZA GIMENEZ LORENZO. Vicepresid.:LARRAZABAL AGUERREVERE MANUEL. Secretario: BOLINAGA HERNANDEZ GUILLERMO. VsecrNoConsj: IC NON RESIDENTSSL. Representan: CABANAS NAVAZO BLANCA PILAR. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n.SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 19, 23 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,ADICION DE NUEVOS ARTICULOS 28 AL 32, Y SE RENUMERAN LOS ARTICULOS 28, 29, 30 Y 31 QUE PASAN A SER LOSARTICULOS 33, 34, 35 Y 36, RESPECTIVAMENTE DE LOS CITADOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 28146 , F 29, S 8, H M507033, I/A 2 ( 3.12.10).

21 de Octubre de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.09.10. Objeto social: 1.-LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORESREPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPA脩OL MEDIANTE LACORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.. Domicilio: PASEO DE LA CASTELLANA 153 -BAJO (MADRID). Capital suscrito: 74.820,00 Euros. Desembolsado: 74.820,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: IC NONRESIDENTS SL. Representan: CABANAS NAVAZO BLANCA PILAR. Apoderado: CABANAS NAVAZO BLANCA PILAR. Datosregistrales. T 28146 , F 26, S 8, H M 507033, I/A 1 (11.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n