Buscador CIF Logo

Actos BORME Pastor Participaciones Preferentes Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pastor Participaciones Preferentes Sa

Actos BORME Pastor Participaciones Preferentes Sa - A15933807

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Pastor Participaciones Preferentes Sa con CIF A15933807

🔙 Perfil de Pastor Participaciones Preferentes Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Pastor Participaciones Preferentes Sa

31 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PARDO GARCIA JOSE;PUERTO GONZALEZ ROBERTO. Nombramientos. Liquidador: GESBANSERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL. Representan: VALENTIN VALENCIA YELMO. Disolución. Voluntaria. Extinción.Datos registrales. T 30131 , F 83, S 8, H M 542345, I/A 21 (24.07.18).

06 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ARMADA MARTINEZ DE CAMPOS SANTIAGO. Datos registrales. T 30131 , F 83, S 8, H M542345, I/A 20 (26.02.18).

06 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BABIO FERNANDEZ JUAN. Nombramientos. Adm. Solid.: ARMADA MARTINEZ DE CAMPOSSANTIAGO. Datos registrales. T 30131 , F 82, S 8, H M 542345, I/A 19 (27.01.17).

23 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30131 , F 82, S 8, H M 542345, I/A18 (13.01.17).

23 de Noviembre de 2016
Modificaciones estatutarias. Refundición de los estatutos sociales.. Suprimidos los artículos 20 bis y 20 ter de los estatutos sociales..Datos registrales. T 30131 , F 81, S 8, H M 542345, I/A 16 (15.11.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARMADA MARTINEZ DE CAMPOS SANTIAGO;DE DIEGO ROZAS DANIEL. Presidente: ARMADAMARTINEZ DE CAMPOS SANTIAGO. Consejero: GARCIA PIEDRAS JOSE ALBERTO;BABIO FERNANDEZ JUAN. Vicepr.1: DEDIEGO ROZAS DANIEL. Vicepr.2: BABIO FERNANDEZ JUAN. Nombramientos. Adm. Solid.: BABIO FERNANDEZ JUAN;PARDOGARCIA JOSE;PUERTO GONZALEZ ROBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administradores solidarios. Datos registrales. T 30131 , F 82, S 8, H M 542345, I/A 17 (15.11.16).

13 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAGA GARCIA MARIA;RUIZ COTERO ARANZAZU. Vicesecret.: COTO OBAYA LAURA.Nombramientos. Consejero: GARCIA PIEDRAS JOSE ALBERTO;BABIO FERNANDEZ JUAN. Vicepr.1: DE DIEGO ROZAS DANIEL.Vicepr.2: BABIO FERNANDEZ JUAN. VsecrNoConsj: DOZ ZUBELDIA CONCEPCION. Datos registrales. T 30131 , F 80, S 8, H M542345, I/A 15 ( 6.06.16).

13 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: BABIO MARTIN GERARDO;JIMENEZ MARTIN FERNANDO;FERNANDEZ GOMEZ MARIA DELCARMEN;GARCIA POZO FRANCISCO JAVIER;GARCIA SANCHEZ MARIA ANGELES;GUZMAN DIAZ SILVIA;PARDO GARCIAJOSE;VILLAVERDE VILLAVERDE SANTIAGO MANUEL;OTERO BLANCO JOSE MARCOS;FUENTES LORO YOLANDA. Apo.Sol.:BABIO MARTIN GERARDO. Nombramientos. Apo.Manc.: PARDO GARCIA JOSE;JIMENEZ MARTIN FERNANDO;FERNANDEZGOMEZ MARIA DEL CARMEN;GARCIA POZO FRANCISCO JAVIER;MARTIN SAEZ PATRICIA;GUZMAN DIAZ SILVIA;OTEROBLANCO JOSE;LOPEZ MEJIAS JESUS MIGUEL;MOINELO LOPEZ TANIA;CORTES GARCIA MARIO. Datos registrales. T 30131 ,

14 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30131 , F 79, S 8, H M 542345, I/A13 ( 7.09.15).

24 de Julio de 2015
Modificaciones estatutarias. 1. Modificación de los articulos 1º, 2º, 8º, 9º, 10º, 13º, 15º, 20º Bis, 20º Ter, 21º y 22º de los EstatutosSociales, para su correcta adaptación a los cambios introducidos por la ley 31/2014, de 3 de diciembre, en la Ley de Sociedades deCapital.. Datos registrales. T 30131 , F 77, S 8, H M 542345, I/A 12 (17.07.15).

23 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ZARATE LACALLE SARA. Consejero: ZARATE LACALLE SARA. M.Comit.Aud: ZARATE LACALLESARA. Datos registrales. T 30131 , F 77, S 8, H M 542345, I/A 11 (14.07.15).

24 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30131 , F 77, S 8, H M 542345, I/A10 (16.10.14).

05 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. M.Comit.Aud: VIVAS SOTILLOS CARLOS. Consejero: GALAN MAS RAFAEL. Vicepresid.: GALAN MASRAFAEL. Consejero: VIVAS SOTILLOS CARLOS. Presidente: RAGA GARCIA MARIA. M.Comit.Aud: GALAN MAS RAFAEL.PreComAudit: VIVAS SOTILLOS CARLOS. Nombramientos. M.Comit.Aud: ZARATE LACALLE SARA. Consejero: ARMADAMARTINEZ DE CAMPOS SANTIAGO;ZARATE LACALLE SARA;DE DIEGO ROZAS DANIEL. Presidente: ARMADA MARTINEZ DECAMPOS SANTIAGO. Vicepresid.: ZARATE LACALLE SARA. M.Comit.Aud: DE DIEGO ROZAS DANIEL. Pte.Comit.Au: RUIZCOTERO ARANZAZU. Reelecciones. M.Comit.Aud: RUIZ COTERO ARANZAZU. Consejero: RAGA GARCIA MARIA;RUIZ COTEROARANZAZU. Datos registrales. T 30131 , F 76, S 8, H M 542345, I/A 9 (27.11.13).

16 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Comisario: RAMA PENAS OSCAR. Nombramientos. Comisario: CABEZA PEREZ ALBERTO. Otrosconceptos: MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA EMISION DE PARTICIPACIONES PREFERENTES INSCRITAS EN LA1& DE TRASLADO DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD EN CUANTO AL CONCEPTO DE BENEFICIO DISTRIBUIBLE , SUSTITUIDOPOR BENEFICIO Y RESERVAS DISTRIBUIBLES.RENOVACION DE LA GARANTIA OTORGADA A LA EMISION INSCRITA POR LA1& DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD POR PARTE DEL BANCO POPULARESPAÑOL SA. Datos registrales. T 30131 , F 75, S 8, H M542345, I/A 8 ( 4.10.13).

08 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30131 , F 75, S 8, H M 542345, I/A7 ( 1.08.13).

26 de Marzo de 2013
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 20 BIS. Datos registrales. T 30131 , F 74, S 8, H M 542345, I/A 6 (15.03.13).

15 de Febrero de 2013
Nombramientos. M.Comit.Aud: VIVAS SOTILLOS CARLOS. PreComAudit: VIVAS SOTILLOS CARLOS. M.Comit.Aud: GALAN MASRAFAEL;RUIZ COTERO ARANZAZU. SecComAudit: GOMEZ MONROY JAVIER. Datos registrales. T 30131 , F 74, S 8, H M542345, I/A 5 ( 7.02.13).

17 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: MORATO MIGUEL CARLOS. Nombramientos. Apo.Manc.: BABIO MARTIN GERARDO;JIMENEZMARTIN FERNANDO;FERNANDEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN;GARCIA POZO FRANCISCO JAVIER;GARCIA SANCHEZ MARIAANGELES;GUZMAN DIAZ SILVIA;PARDO GARCIA JOSE;VILLAVERDE VILLAVERDE SANTIAGO MANUEL;OTERO BLANCO JOSEMARCOS;FUENTES LORO YOLANDA. Apo.Sol.: BABIO MARTIN GERARDO. Datos registrales. T 30131 , F 73, S 8, H M 542345,I/A 4 ( 7.12.12).

11 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30131 , F 73, S 8, H M 542345, I/A3 (29.11.12).

17 de Septiembre de 2012
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID). Datos registrales. T 30131 , F 73, S 8, H M 542345, I/A2 ( 4.09.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información