Actos BORME de Pavimentos Del Genil Sa
04 de Abril de 2022Reelecciones. Consejero: GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Presidente: GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Cons.Del.Man:GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Consejero: REYES RIVERO FRANCISCA. Secretario: REYES RIVERO FRANCISCA.Cons.Del.Man: REYES RIVERO FRANCISCA. Consejero: GONZALEZ REYES ALFONSO JAVIER. Datos registrales. T 774 , F 27, S8, H CO 4846, I/A 30 (24.03.22).
01 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: CEFISA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 774 , F 27, S 8, H CO 4846, I/A 29 (25.01.22).
03 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: CEFISA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 774 , F 26, S 8, H CO 4846, I/A 28 (26.12.18).
03 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ REYES ALVARO. Datos registrales. T 774 , F 26, S 8, H CO 4846, I/A 27 (24.04.17).
09 de Marzo de 2017Reelecciones. Consejero: GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Presidente: GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Cons.Del.Man:GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Consejero: REYES RIVERO FRANCISCA. Secretario: REYES RIVERO FRANCISCA.Cons.Del.Man: REYES RIVERO FRANCISCA. Consejero: GONZALEZ REYES ALFONSO JAVIER. Datos registrales. T 774 , F 26, S8, H CO 4846, I/A 26 ( 2.03.17).
02 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Desembolsado: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 774 , F 25, S 8, H CO 4846, I/A 25 (26.01.17).
21 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: CEFISA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 774 , F 25, S 8, H CO 4846, I/A 24 (14.12.15).
08 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: RUIZ GIL JOSE MANUEL;GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO;REYES RIVERO FRANCISCA. Datosregistrales. T 731 , F 135, S 8, H CO 4846, I/A 23 (29.04.14).
25 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ REYES ALVARO;GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO;REYES RIVERO FRANCISCA.Datos registrales. T 731 , F 135, S 8, H CO 4846, I/A 22 (16.04.14).
02 de Enero de 2013Cambio de objeto social. La fabricaci贸n, distribuci贸n y venta de terrazos, productos de hormig贸n y en general cuantos otros puedanemplearse en la construcci贸n. El transporteterrestre de mercanc铆as de servicio p煤blico por carretera. Datos registrales. T 726 , F 189,S 8, H CO 4846, I/A 20 (24.12.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ GIL JOSE MANUEL;GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO;REYES RIVERO FRANCISCA. Datosregistrales. T 726 , F 189, S 8, H CO 4846, I/A 21 (24.12.12).
12 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: CEFISA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 726 , F 188, S 8, H CO 4846, I/A 19 ( 5.12.12).
24 de Febrero de 2012Reelecciones. Consejero: GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Presidente: GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Cons.Del.Man:GONZALEZ ESCOBAR ALFONSO. Consejero: REYES RIVERO FRANCISCA. Secretario: REYES RIVERO FRANCISCA.Cons.Del.Man: REYES RIVERO FRANCISCA. Consejero: GONZALEZ REYES ALFONSO JAVIER. Datos registrales. T 726 , F 188,S 8, H CO 4846, I/A 18 (15.02.12).
22 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.092.000,00 Euros. Desembolsado: 1.092.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 92.000,00 Euros. Resultante Suscrito:408.000,00 Euros. Datos registrales. T 726 , F 187, S 8, H CO 4846, I/A 17 (13.02.12).
11 de Marzo de 2010Reelecciones. Auditor: CEFISA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 726 , F 187, S 8, H CO 4846, I/A 16 ( 3.03.10).
04 de Septiembre de 2009Fe de erratas: Apoderado mancomunado. Datos registrales. T 726 , F 185, S 8, H CO 4846, I/A 15 (25.08.09).
03 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ REYES ALFONSO JAVIER. Apoderado: REYES RIVERO FRANCISCA. Datos registrales.T 726 , F 185, S 8, H CO 4846, I/A 15 (25.08.09).