Buscador CIF Logo

Actos BORME Pdc Industrial Center 9 Sp Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pdc Industrial Center 9 Sp Sl

Actos BORME Pdc Industrial Center 9 Sp Sl - B01963172

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Pdc Industrial Center 9 Sp Sl con CIF B01963172

馃敊 Perfil de Pdc Industrial Center 9 Sp Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Pdc Industrial Center 9 Sp Sl

09 de Octubre de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.440.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 41149 , F207, S 8, H M 726240, I/A 18 ( 2.10.23).

17 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: CONNOR MARK JAMES;DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;CAMPBELL CARL DAVID;MONTEPASQUALE;WEYH MARC JEAN-LOUP;NEVES ANJA ROGL;RAMOS PAUL;GEUNS EVI;GARCIA COLLADO OSCAR;FERRAZTORRES MIRIAN. Datos registrales. T 41149 , F 205, S 8, H M 726240, I/A 16 (10.03.23).

Nombramientos. Apoderado: CONNOR MARK JAMES;DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;CAMPBELL CARL DAVID;MONTEPASQUALE;WEYH MARC JEAN-LOUP;NEVES ANJA ROGL;RAMOS PAUL;GEUNS EVI;GARCIA COLLADO OSCAR;FERRAZTORRES MIRIAN. Datos registrales. T 41149 , F 206, S 8, H M 726240, I/A 17 (10.03.23).

10 de Febrero de 2023
Modificaciones estatutarias. Incluido un nuevo art铆culo 13 bis de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 41149 , F 205, S 8, HM 726240, I/A 15 ( 3.02.23).

14 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: MOHON BRANDON ROBERTO P. Apoderado: MOHON BRANDON ROBERTO P.;MOHON BRANDONROBERTO P. Nombramientos. Apo.Manc.: CONNOR MARK JAMES;DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;CAMPBELL CARLDAVID;MONTE PASQUALE;WEYH MARC JEAN-LOUP;NEVES ANJA ROGL;RAMOS PAUL;GEUNS EVI;GARCIA COLLADOOSCAR;FERRAZ TORRES MIRIAM. Datos registrales. T 41149 , F 204, S 8, H M 726240, I/A 13 ( 6.10.22).

Nombramientos. Apo.Manc.: CONNOR MARK JAMES;DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;CAMPBELL CARL DAVID;MONTEPASQUALE;WEYH MARC JEAN-LOUP;NEVES ANJA ROGL;RAMOS PAUL;GEUNS EVI. Datos registrales. T 41149 , F 205, S 8, HM 726240, I/A 14 ( 6.10.22).

19 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUDD-JONES JULIAN MARK. Nombramientos. Consejero: BUMPSTEAD DANIEL LEE. Datosregistrales. T 41149 , F 203, S 8, H M 726240, I/A 11 ( 8.04.22).

Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 95 13 - EDIFICIO TORRE EURO (MADRID). Datos registrales. T 41149, F 203, S 8, H M 726240, I/A 12 ( 8.04.22).

27 de Septiembre de 2021
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 95 - PLANTA 9, EDIFICIO TOR (MADRID). Datos registrales. T 41149 ,F 203, S 8, H M 726240, I/A 10 (20.09.21).

27 de Mayo de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.440.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.443.000,00 Euros. Datos registrales. T 41149 , F 201, S8, H M 726240, I/A 9 (20.05.21).

18 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: CONNOR MARK JAMES;DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;CAMPBELL CARL DAVID;MONTEPASQUALE;WEYH MARC JEAN-LOUP;RAMOS PAUL;MOHON BRANDON ROBERTO P.;GEUNS EVI;BEGUIRISTAIN LAHUERTABLANCA;FERRAZ TORRES MIRIAM. Datos registrales. T 41149 , F 201, S 8, H M 726240, I/A 8 (11.05.21).

08 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;VERA CABRERO MIGUEL;MONTE PASQUALE;CAMPBELLCARL DAVID. Datos registrales. T 40942 , F 143, S 8, H M 726240, I/A 6 (30.03.21).

Nombramientos. Apoderado: DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;VERA CABRERO MIGUEL;MONTE PASQUALE;CAMPBELLCARL DAVID. Datos registrales. T 40942 , F 145, S 8, H M 726240, I/A 7 (30.03.21).

08 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: CONNOR MARK JAMES;CARDOZO LUPI GUSTAVO;HARCOURT JOHN BENJAMIN;RUDD-JONESJULIAN MARK. Datos registrales. T 40942 , F 142, S 8, H M 726240, I/A 5 ( 1.03.21).

05 de Marzo de 2021
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA COLLADO OSCAR. Nombramientos.Consejero: HARCOURT JOHN BENJAMIN. Presidente: HARCOURT JOHN BENJAMIN. Consejero: CARDOZO LUPI GUSTAVO.Secretario: CARDOZO LUPI GUSTAVO. Consejero: CONNOR MARK JAMES;RUDD-JONES JULIAN MARK. Modificacionesestatutarias. 6. Modificaci贸n texto art铆culo. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejode administraci贸n. Datos registrales. T 40942 , F 137, S 8, H M 726240, I/A 4 (26.02.21).

03 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: CONNOR MARK JAMES;DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;CAMPBELL CARL DAVID;WEYHMARC JEAN-LOUP;MONTE PASQUALE;RAMOS PAUL;MOHON BRANDON ROBERTO P.;GEUNS EVI. Datos registrales. T 40942, F 136, S 8, H M 726240, I/A 3 (27.01.21).

21 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: CONNOR MARK JAMES;DELSEMME CATHERINE JOSETTE M.;CAMPBELL CARL DAVID;WEYHMARC JEAN-LOUP;RAMOS PAUL;MOHON BRANDON ROBERTO P.;GEUNS EVI. Datos registrales. T 40942 , F 136, S 8, H M726240, I/A 2 (14.12.20).

07 de Octubre de 2020
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.09.20. Objeto social: a) La actividad de gesti贸n y administraci贸n de valoresrepresentativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espa帽ol, mediante la correspondiente organizaci贸n demedios materiales y personales, en los t茅rminos del art铆culo 107 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del... Domicilio: PASEO DE LACASTELLANA 95 - PLANTA 15 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PANATTONISPAIN HOLDING SARL. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA COLLADO OSCAR. Datos registrales. T 40942 , F 134, S 8, H M726240, I/A 1 (30.09.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n