Buscador CIF Logo

Actos BORME Pearson Educacion Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pearson Educacion Sa

Actos BORME Pearson Educacion Sa - A28057701

Tenemos registrados 68 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Pearson Educacion Sa con CIF A28057701

馃敊 Perfil de Pearson Educacion Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Pearson Educacion Sa

29 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PANIZO BURGOS MARIA JESUS;TORRECILLA GIMENO RICARDO. Apo.Manc.: ARRANZ GOMEZMIGUEL ANGEL;PANIZO BURGOS MARIA JESUS. Apo.Sol.: PANIZO BURGOS MARIA JESUS;PANIZO BURGOS MARIA JESUS.Apo.Man.Soli: ILLESCAS NU脩EZ MARTA. Apo.Sol.: ILLESCAS NU脩EZ MARTA. Apoderado: TORRECILLA GIMENORICARDO;PANIZO BURGOS MARIA JESUS;SESMA SANTOS RUTH. Apo.Manc.: PANIZO BURGOS MARIA JESUS;SESMASANTOS RUTH. Apo.Man.Soli: PANIZO BURGOS MARIA JESUS. Apo.Manc.: TORRECILLA GIMENO RICARDO. Apo.Man.Soli:RUBIO SALTO JAVIER. Apoderado: PANIZO BURGOS MARIA JESUS;VEGA LOPEZ OLGA. Datos registrales. T 45777 , F 7, S 8,H M 25475, I/A 283 (21.12.23).

05 de Octubre de 2023
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 85 - PLANTA 8, LOOM COWORKI (MADRID). Datos registrales. T45777 , F 7, S 8, H M 25475, I/A 282 (28.09.23).

04 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RONEY FAJARDO SANDRA. Datos registrales. T 36322 , F 223, S 8, H M 25475, I/A 272(27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIVANCO ARRATIBEL MARIA GLORIA. Datos registrales. T 36322 , F 223, S 8, H M 25475, I/A273 (27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONZO AGRAMONTE EMILSE. Datos registrales. T 36322 , F 224, S 8, H M 25475, I/A 274(27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRECILLA GIMENO RICARDO. Datos registrales. T 36322 , F 225, S 8, H M 25475, I/A 275(27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SESMA SANTOS RUTH. Datos registrales. T 45777 , F 2, S 8, H M 25475, I/A 276 (27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIO SALTO JAVIER. Datos registrales. T 45777 , F 2, S 8, H M 25475, I/A 277 (27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PANIZO BURGOS MARIA JESUS. Datos registrales. T 45777 , F 3, S 8, H M 25475, I/A 278(27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ILLESCAS NU脩EZ MARTA. Datos registrales. T 45777 , F 4, S 8, H M 25475, I/A 279 (27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARRANZ GOMEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 45777 , F 5, S 8, H M 25475, I/A 280(27.09.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: VEGA LOPEZ OLGA. Datos registrales. T 45777 , F 6, S 8, H M 25475, I/A 281 (27.09.23).

11 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ IZQUIERDO ELENA. Apo.Man.Soli: YNZENGA ARANDA FELIPE. Apo.Sol.: PEREZ IZQUIERDOELENA. Apo.Manc.: OSMAN ALAN. Apo.Man.Soli: ROLDAN MONTIEL DOLORES. Apo.Sol.: PEREZ IZQUIERDO ELENA.Apoderado: OSMAN ALAN;GONZALEZ SERRANO ANGEL LUIS. Apo.Manc.: OSMAN ALAN. Apoderado: PEREZ IZQUIERDOELENA. Apo.Manc.: PEREZ IZQUIERDO ELENA. Apoderado: COOPER MARION. Datos registrales. T 36322 , F 222, S 8, H M25475, I/A 271 ( 4.08.23).

17 de Julio de 2023
Reelecciones. Consejero: TORRECILLA GIMENO RICARDO. Datos registrales. T 36322 , F 222, S 8, H M 25475, I/A 270 (7.07.23).

07 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIANI MARIO. Presidente: MARIANI MARIO. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL.Consejero: JAKIMOWICZ MAREK ALEKSANDER. Presidente: JAKIMOWICZ MAREK ALEKSANDER. Datos registrales. T 36322 , F221, S 8, H M 25475, I/A 269 (31.01.23).

13 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36322 , F 221, S 8, H M 25475, I/A268 ( 5.11.20).

05 de Marzo de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36322 , F 221, S 8, H M 25475, I/A267 (27.02.20).

06 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: PANIZO BURGOS MARIA JESUS;VEGA LOPEZ OLGA;COOPER MARION. Datos registrales. T36322 , F 220, S 8, H M 25475, I/A 266 (30.01.20).

23 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOHN PHILLIPS ANDREW. Presidente: JOHN PHILLIPS ANDREW. Nombramientos. Consejero:MARIANI MARIO. Presidente: MARIANI MARIO. Datos registrales. T 36322 , F 220, S 8, H M 25475, I/A 265 (16.01.20).

07 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIO SALTO JAVIER. Datos registrales. T 36322 , F 219, S 8, H M 25475, I/A 264 (30.10.19).

23 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: AFFINITO GIUSEPPE. Secretario: AFFINITO GIUSEPPE. Revocaciones. Apo.Man.Soli: AFFINITOGIUSEPPE. Apo.Manc.: AFFINITO GIUSEPPE;AFFINITO GIUSEPPE. Apo.Sol.: AFFINITO GIUSEPPE. Apoderado: AFFINITOGIUSEPPE. Apo.Manc.: AFFINITO GIUSEPPE. Nombramientos. Consejero: PANIZO BURGOS MARIA JESUS. Secretario: PANIZOBURGOS MARIA JESUS. Apo.Manc.: PEREZ IZQUIERDO ELENA. Apo.Man.Soli: PANIZO BURGOS MARIA JESUS. Apo.Manc.:TORRECILLA GIMENO RICARDO. Otros conceptos: REVOCADO PARCIALMENTE EL PODER CONFERIDO A D陋. MARIA JESUSPANIZO BURGOS EN ESCRITURAS QUE CAUSARON LAS INSCRIPCIONES 250 Y 252. Datos registrales. T 36322 , F 218, S 8, HM 25475, I/A 263 (16.10.19).

05 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: PEREZ IZQUIERDO ELENA. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 260陋 elnombramiento como Apoderado de PEREZ IZQUIERDO ELENA. Datos registrales. T 36322 , F 216, S 8, H M 25475, I/A 260 (2.11.18).

04 de Junio de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SEBASTIAN PASCUAL ALBERTO. Apoderado: SEBASTIAN PASCUAL ALBERTO. Nombramientos.Apoderado: AFFINITO GIUSEPPE;PANIZO BURGOS MARIA JESUS;SESMA SANTOS RUTH. Apo.Manc.: OSMAN ALAN;AFFINITOGIUSEPPE;PANIZO BURGOS MARIA JESUS;SESMA SANTOS RUTH. Datos registrales. T 36322 , F 218, S 8, H M 25475, I/A 262(28.05.19).

11 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36322 , F 217, S 8, H M 25475, I/A261 ( 3.01.19).

14 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO. Presidente: RUIZ DE VELASCO ARANGURENSANTIAGO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO. Apo.Manc.: RUIZ DE VELASCOARANGUREN SANTIAGO;RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO. Apo.Sol.: RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO.Nombramientos. Consejero: JOHN PHILLIPS ANDREW. Presidente: JOHN PHILLIPS ANDREW. Apoderado: OSMANALAN;SEBASTIAN PASCUAL ALBERTO;GONZALEZ SERRANO ANGEL LUIS. Datos registrales. T 36322 , F 216, S 8, H M 25475,I/A 260 ( 2.11.18).

27 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HUERTAS MARRON JAVIER. Apo.Manc.: HUERTAS MARRON JAVIER;HUERTAS MARRONJAVIER. Nombramientos. Apoderado: TORRECILLA GIMENO RICARDO. Datos registrales. T 36322 , F 216, S 8, H M 25475, I/A259 (20.03.18).

15 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36322 , F 216, S 8, H M 25475, I/A258 ( 6.11.17).

31 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: PARRA ROMERO CRISTINA. Nombramientos. Apo.Sol.: ILLESCAS NU脩EZ MARTA;PEREZIZQUIERDO ELENA. Datos registrales. T 33109 , F 159, S 8, H M 25475, I/A 257 (23.10.17).

30 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FORBES GREGOR. Con.Delegado: FORBES GREGOR. Nombramientos. Consejero:TORRECILLA GIMENO RICARDO. VsecrNoConsj: SANCHEZ BLEDA GARCIA PILAR. Datos registrales. T 33109 , F 158, S 8, H M25475, I/A 256 (22.03.17).

29 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ILLESCAS NU脩EZ MARTA. Otros conceptos: Actualizaci贸n del sistema de poderes que causaronlas inscripciones 250, 252 y 253 en la Hoja de la Sociedad, a meros efectos organizativos internos de la misma. Cambio de domiciliosocial. C/ RIBERA DEL LOIRA N潞 16-18 , PLANTA BAJA MODULO (MADRID). Datos registrales. T 33109 , F 157, S 8, H M 25475,I/A 255 (22.03.17).

21 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33109 , F 156, S 8, H M 25475, I/A254 (12.12.16).

14 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: ROS CATALAN MONICA;CASTRO SALGADO JUAN LUIS. Apo.Man.Soli: PEREZ MOCHALES OSCAR.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROLDAN MONTIEL DOLORES. Apo.Sol.: PANIZO BURGOS MARIA JESUS. Apo.Manc.: AFFINITOGIUSEPPE;RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO;HUERTAS MARRON JAVIER. Apo.Sol.: PANIZO BURGOS MARIAJESUS;AFFINITO GIUSEPPE;RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO. Otros conceptos: ampliaci贸n en la redacci贸n de laletra D) de las facultades financieras conferidas en escritura autorizada el 9 de febrero de 2016 con n煤mero 407 de protocolo quecaus贸 la inscripcion 250,. Datos registrales. T 33109 , F 155, S 8, H M 25475, I/A 253 ( 4.11.16).

19 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: KEESS RALF. Consejero: WILLIAMS PAUL MARK. Cons.Del.Sol: WILLIAMS PAUL MARK.Revocaciones. Apoderado: CARAM MORERA PABLO MIGUEL;GARCIA CORRAL MARIA AMAYA. Apo.Man.Soli: KEESSRALF;KEESS RALF. Apo.Sol.: COMPTE ANGUELA DAVID. Nombramientos. Consejero: AFFINITO GIUSEPPE. Secretario:AFFINITO GIUSEPPE. Apo.Manc.: PANIZO BURGOS MARIA JESUS. Apo.Sol.: PEREZ IZQUIERDO ELENA;PARRA ROMEROCRISTINA. Apo.Manc.: HUERTAS MARRON JAVIER;AFFINITO GIUSEPPE;RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO;OSMANALAN. Apo.Sol.: SANCHEZ BLEDA GARCIA PILAR. Datos registrales. T 33109 , F 152, S 8, H M 25475, I/A 252 ( 8.08.16).

18 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33109 , F 152, S 8, H M 25475, I/A251 (11.07.16).

25 de Febrero de 2016
Modificaciones estatutarias. REFUNCION DE ESTATUTOS. . Datos registrales. T 33109 , F 146, S 8, H M 25475, I/A 247(15.02.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CARAM MORERA PABLO MIGUEL. Datos registrales. T 33109 , F 148, S 8, H M 25475, I/A 248

Revocaciones. Apoderado: TORRECILLA GIMENO RICARDO;KEESS RALF;ARRANZ GOMEZ MIGUEL ANGEL;KEESSRALF;CASTRO SALGADO JUAN LUIS;TORRECILLA GIMENO RICARDO. Apo.Sol.: SANCHEZ BLEDA GARCIA PILAR;ABAD COSTPATRICIA;TORRES MAESTRE MARTA;ORDU脩EZ MARTIN MARIA ELENA;VILLAVERDE ANTE BEATRIZ. Apoderado: RUIZ DEVELASCO ARANGUREN SANTIAGO;GOMEZ ARNAU DIAZ CA脩ABATE ADRIANA;ILLESCAS NU脩EZ MARTA;ROS CATALANMONICA;PEREZ MOCHALES OSCAR;WILLIAMS PAUL MARK;GARCIA CORRAL MARIA AMAYA. Apo.Man.Soli: AFFINITOGIUSEPPE;RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO;CARAM MORERA PABLO MIGUEL;PANIZO BURGOS MARIAJESUS;PEREZ MOCHALES OSCAR. Apo.Sol.: YNZENGA ARANDA FELIPE. Otros conceptos: REVOCADO el poder conferido afavor de DO脩A JANE ELIZABETH MARKHAM en escritura otorgada ante el Notario Don Ignacio Solis Villa, el d铆a 8 de junio de 1989con el n煤mero 1.045 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 95& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DO脩A ALICIABUIL GARCIA en escritura otorgada ante el Notario Don Carlos Solis Villa, el d铆a 3 de mayo de 1989 con el n煤mero 755 de protocoloque caus贸 la inscripci贸n 92& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON CARLOS GARCIA MARTIN en escrituraotorgada ante el Notario Don Ignacio Solis Villa, el d铆a 8 de febrero de 1989, con el n煤mero 220 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n89& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON LUIS FERNANDEZ MELCON en escritura otorgada ante el NotarioDon Ignacio Solis Villa el d铆a 24 de enero de 1989 con el n煤mero 133 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 87& de esta hoja.REVOCADO el poder conferido a favor de DO脩A MARIA DEL PILAR ORTERO DA SILVA, en escritura otorgada ante el Notario DonIgnacio Sol铆s Villa, el d铆a 24 de enero de 1989, con el n煤mero 132 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 86& de esta hoja. REVOCADOel poder conferido a favor de DO脩A ISABEL RUIZ PERDIGUERO, en escritura otorgada ante el Notario Don Ignacio Solis Villa, el d铆a24 de marzo de 1988, con el n煤mero 342 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 79& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido afavor de DON RAFAEL FERNANDEZ LAPPI, en escritura otorgada ante el Notario Don Ignacio Solis Villa, el d铆a 19 de mayo de 1986con el n煤mero 1.215 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 75& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON ERICHRUIZ ALBRECHT en escritura otorgada ante el Notario Don Ignacio Sol铆s Villa, el d铆a 19 de mayo de 1986 con el n煤mero 1.214 deprotocolo que caus贸 la inscripci贸n 74& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DO脩A MARIA ISABEL-BRIGIDABETANCORT DOMINGUEZ en escritura otorgada ante el Notario Don Ignacio Solis Villa el d铆a 19 de mayo de 1986, con el n煤mero1.212 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 73& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON ELIAS SANCHEZ DELOS SILOS SALAS en escritura otorgada ante el Notario Don Jose Maria Villanueva Gil el d铆a 17 de septiembre de 1985 con el n煤mero1.051 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 69& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON JAVIER LARIAQUINCOCES en escritura otorgada ante el Notario Don Zacarias Jimenez Asenjo el d铆a 25 de octubre de 1985, con el n煤mero 1247 deprotocolo que caus贸 la inscripci贸n 67& de esta hoja. REVOCADOS los poderes conferidos a favor de DON ROMAN CORTAZARROLLOW y DON JAVIER LARIA QUINCOCES, en escritura otorgada ante el Notario Don Jose Maria Villanueva Gil el d铆a 4 de junio de1985 con el n煤mero 739 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 66& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DONRAFAEL FERNANDEZ LAPPI en escritura otorgada ante el Notario Don Juan Manuel Benavides Gomez, el d铆a 16 de mayo de 1973,con el n煤mero 122 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 64& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON MIGUELANGEL GIMENO SANCHEZen escritura otorgada ante el Notario Don Jose Maria Villanueva Gil el d铆a 9 de febrero de 1983 con eln煤mero 142 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 57& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON VICTOR MANUELVILLANOVA VALERO en escritura otorgada ante el Notario Don Juan Manuel Benavides Gomez, el d铆a 13 de julio de 1979 con eln煤mero 688 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 49& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor de DON JESUSSALVADOR RAMON SANCHEZ NAVARRO, en escritura otorgada ante el Notario Don Juan Manuel Benavides Gomez, el d铆a 4 defebrero de 1981 con el n煤mero 70 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 47& de esta hoja. REVOCADO el poder conferido a favor deDON ERICH RUIZ ALBRECHT, en escritura otorgada ante el Notario Don Ignacio Sol铆s Villa, el d铆a 1 de julio de 1987, con el n煤mero1.673 de protocolo que caus贸 la inscripi贸n 78& de esta hoja. Datos registrales. T 33109 , F 149, S 8, H M 25475, I/A 249 (16.02.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO;AFFINITO GIUSEPPE;KEESS RALF;PANIZOBURGOS MARIA JESUS;HUERTAS MARRON JAVIER;TORRECILLA GIMENO RICARDO. Apo.Sol.: PEREZ IZQUIERDO ELENA.Apo.Man.Soli: YNZENGA ARANDA FELIPE. Apo.Sol.: ROS CATALAN MONICA;CASTRO SALGADO JUAN LUIS. Apo.Man.Soli:PEREZ MOCHALES OSCAR;SEBASTIAN PASCUAL ALBERTO. Apo.Manc.: ARRANZ GOMEZ MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: COMPTEANGUELA DAVID. Datos registrales. T 33109 , F 150, S 8, H M 25475, I/A 250 (16.02.16).

27 de Enero de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 34.726.356,96 Euros. Resultante Suscrito: 251.843,04 Euros. Datos registrales. T 33109 ,F 144, S 8, H M 25475, I/A 246 (18.01.16).

05 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: FORBES GREGOR. Nombramientos. Consejero: RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO.Presidente: RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO. Datos registrales. T 33109 , F 144, S 8, H M 25475, I/A 245 (25.09.15).

20 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: GARCIA HERAS FRANCISCO JOSE;RUBIO SANTO JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: YNZENGAARANDA FELIPE. Datos registrales. T 22729 , F 43, S 8, H M 25475, I/A 244 ( 9.04.15).

11 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22729 , F 43, S 8, H M 25475, I/A243 ( 3.03.15).

24 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: CARAM MORERA PABLO MIGUEL. Nombramientos. Cons.Del.Sol: WILLIAMS PAUL MARK.Apo.Man.Soli: AFFINITO GIUSEPPE;KEESS RALF;RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO;CARAM MORERA PABLOMIGUEL;PANIZO BURGOS MARIA JESUS;PEREZ MOCHALES OSCAR. Datos registrales. T 22729 , F 40, S 8, H M 25475, I/A 242(16.12.14).

21 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAVIN CAUPEIL JUAN CARLOS. Revocaciones. Apoderado: MONTERO MARTINEZILDEFONSO;MORENO NEVADO RAFAEL;GASTELUITURRIA MARTIN IDOIA;CALVO PAREDES MARISA;CAVIN CAUPEIL JUANCARLOS;MENDIOLA GONZALEZ RICARDO;GUTMAN MARIACH VIVIANA CLARA;GRIFFITHS AP SIMON THOMASDAVID;JIMENEZ LAZCANO RODRIGO EXEQUIEL. Nombramientos. Consejero: CARAM MORERA PABLO MIGUEL. Apoderado:CARAM MORERA PABLO MIGUEL;GARCIA CORRAL MARIA AMAYA;RUBIO SANTO JAVIER. Datos registrales. T 22729 , F 38, S8, H M 25475, I/A 241 ( 9.05.14).

24 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SINCLAIR SNADDON MARGARET;KNIGHT JOHN AUSTEN. Con.Delegado: SINCLAIR SNADDONMARGARET. Presidente: KNIGHT JOHN AUSTEN. Nombramientos. Consejero: FORBES GREGOR;WILLIAMS PAUL MARK.Presidente: FORBES GREGOR. Con.Delegado: FORBES GREGOR. Apoderado: WILLIAMS PAUL MARK. Ampliacion del objetosocial. LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE LA TECNOLOGIA... Datos registrales. T 22729 , F 35, S 8,H M 25475, I/A 240 (11.09.13).

25 de Julio de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22729 , F 35, S 8, H M 25475, I/A239 (16.07.13).

18 de Octubre de 2012
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PEARSON LEARNING SOLUTIONS SA. Datos registrales. T 22729 , F 32, S 8, HM 25475, I/A 238 ( 8.10.12).

21 de Junio de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22729 , F 32, S 8, H M 25475, I/A237 (12.06.12).

20 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: RUIZ DE VELASCO ARANGUREN SANTIAGO;CARAM MORERA PABLO MIGUEL;GOMEZ ARNAUDIAZ CA脩ABATE ADRIANA;ILLESCAS NU脩EZ MARTA;ROS CATALAN MONICA;PEREZ MOCHALES OSCAR;GARCIA CORRALMARIA AMAYA;JIMENEZ LAZCANO RODRIGO EXEQUIEL. Datos registrales. T 22729 , F 30, S 8, H M 25475, I/A 236 ( 8.06.12).

23 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: GONZALO PAREDES ANGEL LUIS;COLLADO BITO LUIS;MOZUN MU脩OZ CARMEN;CASTA脩EALVAREZ VERONICA;GARCIA BOENTE DAVILA ANA. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ BLEDA GARCIA PILAR;ABAD COSTPATRICIA;TORRES MAESTRE MARTA;ORDU脩EZ MARTIN MARIA ELENA;VILLAVERDE ANTE BEATRIZ. Datos registrales. T22729 , F 29, S 8, H M 25475, I/A 235 (11.04.12).

04 de Abril de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22729 , F 29, S 8, H M 25475, I/A234 (26.03.12).

09 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: AGUILAR MATEO RAFAEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANCHEZ BLEDA GARCIAPILAR. Datos registrales. T 22729 , F 29, S 8, H M 25475, I/A 233 (27.01.12).

30 de Enero de 2012
Revocaciones. Apoderado: VILLANOVA VALERO VICTOR MANUEL;COMAS FERRER RAMON;BUENDIA TUBIAMANUEL;ANDERSON WILLIAM;WILSON MARK ANDREW;AGUILAR YA脩EZ FELIX;CASTILLO MATEOS CARLOS;CRESPOFUSTER MARIA LUISA;COLLADO BITO LUIS;TORRECILLA GIMENO RICARDO;NICOLAS ALVAREZ MARIA TERESA;ALMARMARQUES RAFAEL;SALGADO VILLALBA FRANCISCO JAVIER;MORENO NEVADO RAFAEL;ORDO脩EZ VILLEGASCONCEPCION. Datos registrales. T 22729 , F 28, S 8, H M 25475, I/A 232 (17.01.12).

25 de Abril de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: BERMUDEZ GONZALEZ GEMA. Apoderado: MOLPECERES GARCIA JESUS MARIANO.Nombramientos. Apoderado: GUTMAN MARIACH VIVIANA CLARA;GRIFFITHS AP SIMON THOMAS DAVID. Datos registrales. T22729 , F 26, S 8, H M 25475, I/A 231 ( 7.04.11).

24 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22729 , F 26, S 8, H M 25475, I/A230 (14.12.10).

28 de Octubre de 2010
Revocaciones. Apoderado: LLOYD ANTHONY EWART;AGUILAR YANES FELIX. Nombramientos. Apoderado: MENDIOLAGONZALEZ RICARDO;TORRECILLA GIMENO RICARDO. Datos registrales. T 22729 , F 24, S 8, H M 25475, I/A 229 (18.10.10).

03 de Mayo de 2010
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 222&, EL OTORGAMIENTO DE PODER DE ALVAREZ NICOLASMARIA TERESA, SIENDO LO CORRRECTO NICOLAS ALVAREZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 22729 , F 19, S 8, H M25475, I/A 222 ( 8.02.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO FUSTER MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: CAVIN CAUPEIL JUAN CARLOS.Datos registrales. T 22729 , F 22, S 8, H M 25475, I/A 224 (22.04.10).

Nombramientos. Apoderado: CAVIN CAUPEIL JUAN CARLOS. Datos registrales. T 22729 , F 22, S 8, H M 25475, I/A 226(22.04.10).

Nombramientos. Apoderado: MOZUN MU脩OZ CARMEN;CASTA脩E ALVAREZ VERONICA;GARCIA BOENTE DAVILA ANA. Datosregistrales. T 22729 , F 23, S 8, H M 25475, I/A 227 (22.04.10).

Revocaciones. Apoderado: CRESPO FUSTER MARIA LUISA;ZOFIO GARCIA PEDRO;CRESPO FUSTER MARIA LUISA. Datos

Revocaciones. Apoderado: GASCON ESTEVAS DANIEL;BENAVENTE ALBA CARLOS;CRESPO FUSTER MARIA LUISA;ALMARMARQUES RAFAEL;BETETA CASTEJON JIMENA ENCARNACION;ORDO脩EZ VILLEGAS CONCEPCION;NICOLAS ALVAREZMARIA TERESA;CASTILLO MATEOS CARLOS. Datos registrales. T 22729 , F 22, S 8, H M 25475, I/A 225 (22.04.10).

23 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22729 , F 21, S 8, H M 25475, I/A223 (10.02.10).

18 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apoderado: LLOYD ANTHONY EWART;ARRANZ GOMEZ MIGUEL ANGEL;KEESS RALF;BENAVENTE ALBACARLOS;CRESPO FUSTER MARIA LUISA;ALMAR MARQUES RAFAEL;BETETA CASTEJON JIMENA ENCARNACION;ORDO脩EZVILLEGAS CONCEPCION;AGUILAR YANES FELIX;ALVAREZ NICOLAS MARIA TERESA;MOLPECERES GARCIA JESUSMARIANO;GARCIA HERAS FRANCISCO JOSE;MONTERO MARTINEZ ILDEFONSO;CASTILLO MATEOS CARLOS;MORENONEVADO RAFAEL;CASTRO SALGADO JUAN LUIS;GASTELUITURRIA MARTIN IDOIA;CALVO PAREDES MARISA. Datosregistrales. T 22729 , F 19, S 8, H M 25475, I/A 222 ( 8.02.10).

05 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ SEVILLA ALBERTO. Consejero: ANDERSON WILLIAM. Presidente: ANDERSONWILLIAM. Con.Delegado: ANDERSON WILLIAM. Consejero: ETHRIDGE JR WILLIAM THAYER;LOCKIE VICTORIA MARY.Nombramientos. SecreNoConsj: KEESS RALF. Consejero: SINCLAIR SNADDON MARGARET;KNIGHT JOHN AUSTEN;CRESPOFUSTER MARIA LUISA. Presidente: KNIGHT JOHN AUSTEN. Con.Delegado: SINCLAIR SNADDON MARGARET. VsecrNoConsj:AGUILAR MATEO RAFAEL. Datos registrales. T 22729 , F 18, S 8, H M 25475, I/A 220 (27.01.10).

Revocaciones. Apoderado: BENAVENTE ALBA CARLOS;ALMAR MARQUES RAFAEL;CRESPO FUSTER MARIA LUISA;ARRANZGOMEZ MIGUEL ANGEL;KEESS RALF;BETETA CASTEJON JIMENA ENCARNACION;ORDO脩EZ VILLEGASCONCEPCION;AGUILAR YANES FELIX;NICOLAS ALVAREZ MARIA TERESA;DOS SANTOS GODOY PI脩EIRO PEDROMANUEL;MOLPECERES GARCIA JESUS MARIANO;GARCIA HERAS FRANCISCO JOSE;MONTERO MARTINEZILDEFONSO;BERMUDEZ GONZALEZ GEMA;CASTILLO MATEOS CARLOS;MORENO NEVADO RAFAEL;CASTRO SALGADOJUAN LUIS;GASTELUITURRIA MARTIN IDOIA;CALVO PAREDES MARISA. Nombramientos. Apoderado: KEESS RALF;CRESPOFUSTER MARIA LUISA. Datos registrales. T 22729 , F 19, S 8, H M 25475, I/A 221 (27.01.10).

02 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22729 , F 17, S 8, H M 25475, I/A219 (21.01.10).

19 de Octubre de 2009
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SEVILLA ALBERTO. Datos registrales. T 22729 , F 17, S 8, H M 25475, I/A 218 (6.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n