Buscador CIF Logo

Actos BORME Pepper Assets Services Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pepper Assets Services Sl

Actos BORME Pepper Assets Services Sl - B86615945

Tenemos registrados 56 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Pepper Assets Services Sl con CIF B86615945

馃敊 Perfil de Pepper Assets Services Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Pepper Assets Services Sl

20 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Consejero: GARCIA GONZALEZ FERNANDO. Datos registrales. T 37978 , F 193, S 8, H M 550413, I/A 62(13.11.23).

02 de Octubre de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PEPPER SPANISH MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED. Datosregistrales. T 37978 , F 193, S 8, H M 550413, I/A 61 (25.09.23).

22 de Septiembre de 2023
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.907.762,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.640.126,00 Euros. Datos registrales. T 37978 , F 192, S8, H M 550413, I/A 59 (15.09.23).

Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 7潞 y 8潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 37978 , F 193, S 8, HM 550413, I/A 60 (15.09.23).

04 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: PERERA RIVAS ANAMAR. Apo.Sol.: PERERA RIVAS ANAMAR. Datos registrales. T 37978 , F 192, S8, H M 550413, I/A 58 (28.03.23).

09 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37978 , F 191, S 8, H M 550413, I/A 56 ( 2.03.23).

Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA SANCHEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 37978 , F 192, S 8, H M 550413, I/A 57 (2.03.23).

13 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: LUCIA LOPEZ MAGALLON. Datos registrales. T 37978 , F 191, S 8, H M 550413, I/A 55 ( 6.02.23).

16 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: VIGIL BLANCO VANESA;DEL CASTILLO ENCABO IGNACIO. Datos registrales. T 37978 , F 191, S 8,H M 550413, I/A 54 ( 9.12.22).

04 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: DEL ROMO GOMEZ JOSE FELIX;DEL ROMO GOMEZ JOSE FELIX;DEL ROMO GOMEZ JOSE FELIX.Datos registrales. T 37978 , F 189, S 8, H M 550413, I/A 50 (27.10.22).

13 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GONZALEZ FERNANDO. Datos registrales. T 37978 , F 187, S 8, H M 550413, I/A 49 (6.07.22).

22 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: REYERO SIMON ALVARO JOSE. Datos registrales. T 37978 , F 187, S 8, H M 550413, I/A 48(13.04.22).

25 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GUINEA ALONSO MARIA INES;URIA CASATEJADA GLORIA. Datos registrales. T 37978 , F 187, S 8,H M 550413, I/A 47 (18.02.22).

21 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: REYERO SIMON JOSE ALVARO. Datos registrales. T 37978 , F 185, S 8, H M 550413, I/A 46(14.02.22).

22 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37978 , F 184, S 8, H M 550413, I/A 44 (15.11.21).

Revocaciones. Apoderado: DE LAS HERAS HERNANDEZ VICTOR. Apo.Sol.: FURONES AMBIT SILVIA;MONTORO GAMARROJAIME. Apoderado: NAVARRO GONZALEZ MARIA TERESA;MACIAS GARCIA OLGA;ROBUFFO REYNA MARIACONSTANZA;PERAL ROS SERGIO;MACIAS GARCIA OLGA;NAVARRO GONZALEZ MARIA TERESA;PERAL ROSSERGIO;MONTORO GAMARRO JAIME;FURONES AMBIT SILVIA;GONZALEZ SANCHEZ SONIA;MARTINEZ REINOLUCIA;MACIAS GARCIA OLGA;NAVARRO GONZALEZ MARIA TERESA;PERAL ROS SERGIO;MONTORO GAMARROJAIME;FURONES AMBIT SILVIA;GONZALEZ SANCHEZ SONIA;MARTINEZ REINO LUCIA;GONCALVES MARIANAMITTEL;PEREDO PEREZ ALVARO. Datos registrales. T 37978 , F 185, S 8, H M 550413, I/A 45 (15.11.21).

04 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apoderado: DEL ROMO GOMEZ JOSE FELIX;PERERA RIVAS ANAMAR. Datos registrales. T 37978 , F 182, S8, H M 550413, I/A 43 (28.07.21).

03 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apoderado: DE LAS HERAS HERNANDEZ VICTOR. Datos registrales. T 37978 , F 182, S 8, H M 550413, I/A 42(27.07.21).

05 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ESTEBAN BEATRIZ;GONZALEZ SANCHEZ SONIA;DEL ROMO GOMEZ JOSEFELIX;MARTINEZ REINO LUCIA;GARCIA GONZALEZ FERNANDO. Datos registrales. T 37978 , F 182, S 8, H M 550413, I/A 41(25.03.21).

03 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37978 , F 181, S 8, H M 550413, I/A 40 (24.02.21).

27 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: GONCALVES MARIANA MITTEL;PEREDO PEREZ ALVARO. Datos registrales. T 37978 , F 181, S 8,H M 550413, I/A 39 (22.03.20).

19 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37978 , F 181, S 8, H M 550413, I/A 38 (12.02.20).

30 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA SANCHEZ FRANCISCO;ARNAIZ GIMENEZ-CORAL GUILLERMO;DE LAS HERASHERNANDEZ VICTOR;DEL ROMO GOMEZ JOSE FELIX. Datos registrales. T 37978 , F 179, S 8, H M 550413, I/A 37 (23.10.19).

20 de Septiembre de 2019
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 37978 , F 175,S 8, H M 550413, I/A 36 (13.09.19).

26 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37978 , F 175, S 8, H M 550413, I/A 35 (19.03.19).

23 de Enero de 2019
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: VESTA ASSET MANAGEMENT SL. Datos registrales. T 37978 , F 174, S 8, H M550413, I/A 34 (16.01.19).

27 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37978 , F 173, S 8, H M 550413, I/A 33 (19.12.18).

22 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: MACIAS GARCIA OLGA;NAVARRO GONZALEZ MARIA TERESA;PERAL ROS SERGIO;MONTOROGAMARRO JAIME;FURONES AMBIT SILVIA;GONZALEZ SANCHEZ SONIA;MARTINEZ REINO LUCIA. Datos registrales. T 30665 ,F 79, S 8, H M 550413, I/A 31 (15.10.18).

Nombramientos. Apoderado: MACIAS GARCIA OLGA;NAVARRO GONZALEZ MARIA TERESA;PERAL ROS SERGIO;MONTOROGAMARRO JAIME;FURONES AMBIT SILVIA;GONZALEZ SANCHEZ SONIA;MARTINEZ REINO LUCIA. Datos registrales. T 37978 ,F 172, S 8, H M 550413, I/A 32 (15.10.18).

25 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: MONTOYA REGUERA CARLOS. Datos registrales. T 30665 , F 79, S 8, H M 550413, I/A 30 (18.04.18).

04 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTOYA REGUERA CARLOS. SecreNoConsj: ARNAIZ GIMENEZ-CORAL GUILLERMO.Nombramientos. Consejero: ARNAIZ GIMENEZ-CORAL GUILLERMO. Secretario: ARNAIZ GIMENEZ-CORAL GUILLERMO. Datosregistrales. T 30665 , F 79, S 8, H M 550413, I/A 29 (23.03.18).

22 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30665 , F 79, S 8, H M 550413, I/A 28 (13.02.18).

30 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: TUTTLE PATRICK EDMUND. Datos registrales. T 30665 , F 78, S 8, H M 550413, I/A 27 (22.06.17).

29 de Junio de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.366.075,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.402.281,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.330.083,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.732.364,00 Euros. Datos registrales. T 30665 , F 78, S 8, H M 550413, I/A 26 (15.06.17).

11 de Abril de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PEPPER SPANISH HOLDING LIMITED. Datos registrales. T 30665, F 78, S 8, H M 550413, I/A 25 ( 4.04.17).

04 de Abril de 2017
Otros conceptos: subsanaci贸n del error padecido en la escritura de poder que caus贸 la inscripci贸n 21 en cuanto al modo de ejerciciode las facultades. Datos registrales. T 30665 , F 77, S 8, H M 550413, I/A 24 (27.03.17).

16 de Marzo de 2017
Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA ORIGEN DE LA INSCRIPCION 22, EN CUANTO AL MODO DE EJERCICIO DELAS FACULTADES.- Datos registrales. T 30665 , F 77, S 8, H M 550413, I/A 23 ( 8.03.17).

24 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: ROBUFFO REYNA MARIA CONSTANZA;PERAL ROS SERGIO. Datos registrales. T 30665 , F 77, S8, H M 550413, I/A 22 (17.02.17).

22 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO GONZALEZ MARIA TERESA;MACIAS GARCIA OLGA. Datos registrales. T 30665 , F 76,S 8, H M 550413, I/A 21 (14.02.17).

10 de Mayo de 2016
Nombramientos. Consejero: MONTOYA REGUERA CARLOS. Datos registrales. T 30665 , F 76, S 8, H M 550413, I/A 20 (3.05.16).

09 de Marzo de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.463.794,00 Euros. Resultante Suscrito: 36.206,00 Euros. Datos registrales. T 30665 , F76, S 8, H M 550413, I/A 19 ( 1.03.16).

11 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apoderado: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ;CASTA脩ON MARTINEZESPERANZA;GONZALEZ YA脩EZ DANIEL;OSACAR IBARROLA ALBERTO. Datos registrales. T 30665 , F 75, S 8, H M 550413, I/A18 (30.04.15).

26 de Marzo de 2015
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 7& EL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE A SANCHEZPEDRAZA FRANCISCO, SIENDO LO CORRECTO PEDRAZA SANCHEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 30665 , F 70, S 8, H M550413, I/A 7 (23.09.13).

18 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: LUCAS HERNANDEZ AMALIA. Datos registrales. T 30665 , F 75, S 8, H M 550413, I/A 17 (10.02.15).

16 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIN ARTEAGA ENRIQUE JAVIER. Datos registrales. T 30665 , F 75, S 8, H M 550413, I/A 16 (7.01.15).

30 de Diciembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.497.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 30665 , F 74, S8, H M 550413, I/A 15 (22.12.14).

14 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: FURONES AMBIT SILVIA;MONTORO GAMARRO JAIME;GONZALEZ SANCHEZ SONIA;LUCASHERNANDEZ AMALIA;MARTINEZ REINO LUCIA;MARTINEZ ESTEBAN BEATRIZ. Datos registrales. T 30665 , F 73, S 8, H M550413, I/A 14 ( 4.11.14).

16 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA;FURONES AMBIT SILVIA;NAVARRO GONZALEZMARIA TERESA;MACIAS GARCIA OLGA. Datos registrales. T 30665 , F 72, S 8, H M 550413, I/A 12 ( 6.06.14).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA GONZALEZ FERNANDO. Datos registrales. T 30665 , F 73, S 8, H M 550413, I/A 13 (6.06.14).

17 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA. Datos registrales. T 30665 , F 71, S 8, H M550413, I/A 9 (10.01.14).

Nombramientos. Apoderado: FURONES AMBIT SILVIA. Datos registrales. T 30665 , F 71, S 8, H M 550413, I/A 10 (10.01.14).

Nombramientos. Apoderado: NAVARRO GONZALEZ MARIA TERESA;MACIAS GARCIA OLGA. Datos registrales. T 30665 , F 72,S 8, H M 550413, I/A 11 (10.01.14).

11 de Octubre de 2013
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30665 , F 71, S 8, H M 550413, I/A 8 ( 3.10.13).

01 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAKALLI TEUTA;OSACAR IBARROLA ALBERTO;INTERTRUST (SPAIN) SA. Presidente: BAKALLITEUTA. Secretario: INTERTRUST (SPAIN) SA. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Nombramientos. Consejero: TUTTLEPATRICK EDMUND;CULHANE MICHAEL CHARLES;MARIN ARTEAGA ENRIQUE JAVIER;PEDRAZA SANCHEZ FRANCISCO.Presidente: CULHANE MICHAEL CHARLES. Vicepresid.: SANCHEZ PEDRAZA FRANCISCO. SecreNoConsj: ARNAIZ GIMENEZ-CORAL GUILLERMO. Cambio de domicilio social. C/ JUAN ESPLANDIU 13 C1 (MADRID). Cambio de objeto social. Laprestaci贸n del servicio de gesti贸n, administraci贸n y cobro de todo tipo de pr茅stamos, cr茅ditos y otros productos financieros por cuentapropia o de terceros; el an谩lisis de datos e informaci贸n financiera y de carteras crediticios; la investigaci贸n a efectos de valoraci贸n decr茅ditos; los servicio. Datos registrales. T 30665 , F 70, S 8, H M 550413, I/A 7 (23.09.13).

25 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA SANCHEZ FRANCISCO;MONTOYA REGUERA CARLOS;ARNAIZ GIMENEZ CORALGUILLERMO;DE LAS HERAS HERNANDEZ VICTOR. Datos registrales. T 30580 , F 140, S 8, H M 550413, I/A 6 (14.03.13).

20 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INTERTRUST (SPAIN) SA. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Nombramientos. Consejero:BAKALLI TEUTA;OSACAR IBARROLA ALBERTO;INTERTRUST (SPAIN) SA. Presidente: BAKALLI TEUTA. Secretario: INTERTRUST(SPAIN) SA. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 30580 , F 139, S 8, H M 550413, I/A 5 (12.02.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n