Actos BORME de Perez Rumbao Sa
04 de Octubre de 2023Revocaciones. Apoderado: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Datos registrales. T 924 , F 47, S 8, H OR 2078, I/A 65 (26.09.23).
21 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA;DOMINGUEZ SALGADO MIGUEL;MARTINEZ COSTA JUANMANUELApo.Sol.: FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA. Datos registrales. T 924 , F 47, S 8, H OR 2078, I/A 63 (13.02.23).
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA;DOMINGUEZ SALGADO MIGUEL;SALGADO SALGADO JAVIER.Apo.Sol.: FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA. Datos registrales. T 924 , F 47, S 8, H OR 2078, I/A 64 (13.02.23).
31 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 924 , F 46, S 8, H OR 2078, I/A 62 (21.12.21).
20 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: PEREZ BELLIDO EMILIO. Datos registrales. T 924 , F 46, S 8, H OR 2078, I/A 61 (13.08.21).
Nombramientos. Apoderado: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Datos registrales. T 924 , F 46, S 8, H OR 2078, I/A 60 (13.08.21).
11 de Mayo de 2021Nombramientos. Vicepresid.: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Datos registrales. T 924 , F 45, S 8, H OR 2078, I/A 59 ( 4.05.21).
05 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Consejero: PEREZNIETO JOSE RAMON. Vicepresid.: PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Nombramientos. Presidente: PEREZ BELLIDO JOAQUIN.Consejero: PEREZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 924 , F 45, S 8, H OR 2078, I/A 58 (19.02.21).
04 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ PEREZ JUAN LUIS;GUELL CANCELA JUAN RAMON;VILLANUEVA PRIETO FRANCISCODARIO;GAGO RODRIGUEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: PEREZ BELLIDO EMILIO;DIAZ PEREZ JUAN LUIS. Datos
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Consejero: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE.Nombramientos. Vicepresid.: PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Cons.Del.Sol: PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Datos registrales. T 826 , F194, S 8, H OR 2078, I/A 56 (18.11.20).
06 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: CARIDE ALONSO MARIA JESUS. Datos registrales. T 826 , F 194, S 8, H OR 2078, I/A 55(21.10.20).
02 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ NIETO MARIATERESA;PEREZ MARTINEZ ELOY;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA;PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Presidente: PEREZ NIETO JOSERAMON. Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Consejero: SEIJAS PEREZ BEATRIZCARLOTA. Nombramientos. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ NIETOMARIA TERESA;PEREZ MARTINEZ ELOY;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA;PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Presidente: PEREZ NIETOJOSE RAMON. Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Consejero: SEIJAS PEREZBEATRIZ CARLOTA. Reelecciones. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE. Datos registrales. T 826 , F 194, S 8, H OR 2078,I/A 54 (24.07.19).
02 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SEIJAS PEREZ MARIA ROSARIO. Nombramientos. Consejero: SEIJAS PEREZ BEATRIZCARLOTA. Datos registrales. T 826 , F 193, S 8, H OR 2078, I/A 53 (24.06.19).
08 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 826 , F 193, S8, H OR 2078, I/A 52 (26.10.18).
21 de Agosto de 2018Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 22 de los Estatutos Sociales en cuanto a que el cargo de administrador ser谩 retribuido.Datos registrales. T 826 , F 192, S 8, H OR 2078, I/A 50 ( 8.08.18).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.000.007,80 Euros. Desembolsado: 2.000.007,80 Euros. Resultante Suscrito: 4.210.185,30 Euros.Resultante Desembolsado: 4.210.185,30 Euros. Datos registrales. T 826 , F 193, S 8, H OR 2078, I/A 51 ( 8.08.18).
03 de Abril de 2018Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 826 , F 192, S 8, H OR 2078, I/A 49 (20.03.18).
22 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA;DOMINGUEZ SALGADO MIGUEL;SALGADO SALGADOJAVIER. Apo.Sol.: FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA. Datos registrales. T 826 , F 192, S 8, H OR 2078, I/A 48 ( 7.08.17).
06 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ BELLIDO EMILIO;PEREZ BELLIDO FARA;PEREZ MARTINEZ ISABEL. Nombramientos.Consejero: DIAZ PEREZ JUAN LUIS;GUELL CANCELA JUAN RAMON;VILLANUEVA PRIETO FRANCISCO DARIO;GAGORODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 826 , F 191, S 8, H OR 2078, I/A 47 (23.02.15).
31 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ BELLIDOEMILIO;PEREZ BELLIDO FARA;PEREZ NIETO MARIA TERESA;PEREZ MARTINEZ ISABEL;PEREZ MARTINEZ ELOY;SEIJASPEREZ RAMON MARIA;SEIJAS PEREZ MARIA ROSARIO;PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE.Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ NIETO JOSE RAMON. Presidente: PEREZ NIETO JOSE RAMON.Nombramientos. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ BELLIDOEMILIO;PEREZ BELLIDO FARA;PEREZ NIETO MARIA TERESA;PEREZ MARTINEZ ISABEL;PEREZ MARTINEZ ELOY;SEIJASPEREZ RAMON MARIA;SEIJAS PEREZ MARIA ROSARIO;PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE.Presidente: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE.Datos registrales. T 826 , F 191, S 8, H OR 2078, I/A 46 (21.07.14).
28 de Noviembre de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ANSI INVERSIONES SL. Datos registrales. T 810 , F 75, S 8, H OR 2078, I/A 45(14.11.12).
23 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Vicepresid.: PEREZ NIETO JOSE RAMON.Nombramientos. Presidente: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Datos registrales. T 810 , F 75, S 8, H OR 2078, I/A 44 (10.05.12).
09 de Febrero de 2012Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: DOE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SL. Datos registrales. T 810 , F72, S 8, H OR 2078, I/A 43 (18.01.12).
18 de Abril de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 245.562,59 Euros. Resultante Suscrito: 2.210.177,50 Euros. Datos registrales. T 810 , F72, S 8, H OR 2078, I/A 42 ( 1.04.11).
01 de Febrero de 2011Otros conceptos: Modificaci贸n del art铆culo 22 de los Estatutos Sociales, referente a que el cargo de administrador ser谩 retribuido.Datos registrales. T 810 , F 72, S 8, H OR 2078, I/A 40 (12.01.11).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AICENCAR SL. Datos registrales. T 810 , F 72, S 8, H OR 2078, I/A 41 (12.01.11).
04 de Enero de 2011Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 525 , F 147, S 8, H OR 2078, I/A 39 (20.12.10).
19 de Octubre de 2009Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 525 , F 147, S 8, H OR 2078, I/A 38 ( 7.10.09).
06 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ BELLIDOEMILIO;PEREZ NIETO MARIA TERESA;PEREZ MARTINEZ ISABEL;PEREZ BELLIDO JOAQUIN;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA.Presidente: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Vicepresid.: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO JOSERAMON;PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE. Nombramientos. Consejero: PEREZNIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ BELLIDO EMILIO;PEREZ BELLIDO FARA;PEREZ NIETOMARIA TERESA;PEREZ MARTINEZ ISABEL;PEREZ MARTINEZ ELOY;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA;SEIJAS PEREZ MARIAROSARIO;PEREZ BELLIDO JOAQUIN. Presidente: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Vicepresid.: PEREZ NIETO JOSERAMON. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE. Cons.Del.Sol: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ NIETO JOSERAMON. Datos registrales. T 525 , F 147, S 8, H OR 2078, I/A 37 (24.07.09).
13 de Enero de 2009Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 525 , F 146, S 8, H OR 2078, I/A 36 (20.12.08).