Buscador CIF Logo

Actos BORME Perseus Inversiones S I C A V Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Perseus Inversiones S I C A V Sa

Actos BORME Perseus Inversiones S I C A V Sa - A82161225

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Perseus Inversiones S I C A V Sa con CIF A82161225

馃敊 Perfil de Perseus Inversiones S I C A V Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Perseus Inversiones S I C A V Sa

26 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GARCIA BENJAMIN;LEBOREIRO ENRIQUEZ GUILLERMO. Secretario: LEBOREIROENRIQUEZ GUILLERMO. Consejero: NOTARIO VACAS TOMAS. Presidente: NOTARIO VACAS TOMAS. Ent. Gestora: SANTANDERPRIVATE BANKING GESTION SOCIEDAD ANONIMA. EntidDeposit: CACEIS BANK SPAIN SA. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. LiquiSoli: MARTIN GARCIA BENJAMIN;NOTARIO VACASTOMAS;LEBOREIRO ENRIQUEZ GUILLERMO. Otros conceptos: QUEDA CESADA LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOSSISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES S.A. (IBERCLEAR) COMO ENTIDAD ENCARGADADE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 20346 , F 155, S 8, H M221584, I/A 58 (19.01.23).

10 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 20346 , F 155, S 8, H M 221584,I/A 57 ( 2.11.21).

16 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CABO LOPEZ VIRGINIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: ROJO RIVERA MARIA ELENA.Datos registrales. T 20346 , F 155, S 8, H M 221584, I/A 56 ( 9.06.21).

25 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 20346 , F 154, S 8, H M 221584,I/A 55 (18.02.21).

11 de Diciembre de 2018
Cambio de domicilio social. C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID). Datos registrales. T 20346 , F 154, S 8, H M221584, I/A 54 ( 3.12.18).

24 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ ARRANZ SUSANA. Nombramientos. VsecrNoConsj: CABO LOPEZ VIRGINIA.Datos registrales. T 20346 , F 154, S 8, H M 221584, I/A 53 (17.09.18).

03 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MALVAR GONZALEZ MARIA DE LA CONCEPCION. Secretario: MALVAR GONZALEZ MARIA DE LACONCEPCION. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: LEBORERIROENRIQUEZ GUILLERMO. Secretario: LEBORERIRO ENRIQUEZ GUILLERMO. Reelecciones. Consejero: MARTIN GARCIABENJAMIN;NOTARIO VACAS TOMAS. Presidente: NOTARIO VACAS TOMAS. Datos registrales. T 20346 , F 153, S 8, H M221584, I/A 52 (25.09.17).

21 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 153, S 8, H M 221584, I/A 51 (13.09.16).

10 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. EntidDeposit: SANTANDER INVESTMENT SA. Nombramientos. EntidDeposit: SANTANDER SECURITIESSERVICES SA. Modificaciones estatutarias. 1. Denominaci贸n.-. Datos registrales. T 20346 , F 153, S 8, H M 221584, I/A 50 (1.12.15).

27 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO SANCHEZ ANGEL. Secretario: ROMERO SANCHEZ ANGEL. Nombramientos.Consejero: MALVAR GONZALEZ MARIA DE LA CONCEPCION. Secretario: MALVAR GONZALEZ MARIA DE LA CONCEPCION.Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 152, S 8, H M 221584, I/A 49 (19.10.15).

19 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: NOTARIO VACAS TOMAS. Nombramientos. Apoderado: NOTARIO VACASTOMAS;SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 20346 , F 151, S 8, H M 221584,I/A 48 (11.06.15).

31 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MOLINA RAFAEL;MOLINA DEL POZO ELENA;CESPEDES LEON ARACELI. Datosregistrales. T 20346 , F 151, S 8, H M 221584, I/A 47 (23.12.14).

26 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Ent. Gestora: BANESTO BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA. Nombramientos. Ent. Gestora: SANTANDERPRIVATE BANKING GESTION SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 20346 , F 150, S 8, H M 221584, I/A 46 (17.12.14).

18 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 150, S 8, H M 221584, I/A 45 (10.09.14).

26 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 150, S 8, H M 221584, I/A 44 (18.11.13).

29 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. EntidDeposit: BANCO ESPA脩OL DE CREDITO SA. Nombramientos. EntidDeposit: SANTANDERINVESTMENT SA. Modificaciones estatutarias. 1. Denominaci贸n social y regimen juridico. Designacion del Depositario.. Otrosconceptos: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 20346 , F 148, S 8, H M221584, I/A 43 (18.10.13).

08 de Octubre de 2013
Nombramientos. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ ARRANZ SUSANA. Datos registrales. T 20346 , F 147, S 8, H M 221584, I/A 42(30.09.13).

07 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Con.Delegado: NOTARIO VACAS TOMAS. Datos registrales. T 20346 , F 147, S 8, H M 221584, I/A 41(25.10.12).

06 de Noviembre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 147, S 8, H M 221584, I/A 40 (24.10.12).

24 de Octubre de 2012
Reelecciones. Consejero: NOTARIO VACAS TOMAS. Presidente: NOTARIO VACAS TOMAS. Consejero: MARTIN GARCIABENJAMIN. Otros conceptos: Ratificado el nombramiento como Consejero y Secretario de DON ANGEL ROMEROSANCHEZ.Fecha de ratificaci贸n: 28/06/12-Fechade terminaci贸n: 28/06/17. Datos registrales. T 20346 , F 146, S 8, H M 221584, I/A39 (11.10.12).

02 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: ARRIMADAS GARCIA PILAR MARIA. Datos registrales. T 20346 , F 146, S 8, H M 221584, I/A 38(21.06.12).

11 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ MOSQUERA FERNANDO. Secretario: RODRIGUEZ MOSQUERA FERNANDO.Nombramientos. Consejero: ROMERO SANCHEZ ANGEL. Secretario: ROMERO SANCHEZ ANGEL. Datos registrales. T 20346 ,F 146, S 8, H M 221584, I/A 37 (30.05.12).

14 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 146, S 8, H M 221584, I/A 36 (31.10.11).

07 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: ESCUDERO LEMUS AMPARO;DE LUIS VILLOTA JAVIER;CABEZAS VILLANUEVA MARIA.Nombramientos. Apoderado: ARRIMADAS GARCIA PILAR MARIA. Datos registrales. T 20346 , F 145, S 8, H M 221584, I/A 35(26.10.11).

04 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 145, S 8, H M 221584, I/A 34 (25.10.10).

26 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20346 , F 145, S 8, H M 221584, I/A 33 (16.11.09).

11 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: CABEZAS VILLANUEVA MARIA;MOLINA DEL POZO ELENA;CESPEDES LEON ARACELI. Datosregistrales. T 20346 , F 145, S 8, H M 221584, I/A 32 ( 1.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n