Actos BORME de Petrel 92 Sl
02 de Enero de 2023Nombramientos. Auditor: PRB AUDIT PARTNERS SLP. Datos registrales. T 2474 , F 159, S 8, H A 2402, I/A 18 (22.12.22).
27 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: ALIAUDIT CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2474 , F 159, S 8, H A 2402, I/A 17 (19.11.19).
22 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: POVEDA BELTRAN JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 2474 , F 158, S 8, H A 2402, I/A 16(14.11.19).
18 de Marzo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.043,40 Euros. Resultante Suscrito: 9.976,60 Euros. Datos registrales. T 2474 , F 158, S8, H A 2402, I/A 15 ( 8.03.19).
30 de Noviembre de 2016Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP. Datos registrales. T 2474 , F 158, S 8, H A 2402, I/A 14(22.11.16).
30 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. ARTICULO 13潞.- DURACION Y RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datosregistrales. T 2474 , F 158, S 8, H A 2402, I/A 13 (23.09.14).
08 de Enero de 2014Nombramientos. Auditor: PRIETO PASTOR CARMEN. Datos registrales. T 2474 , F 158, S 8, H A 2402, I/A 12 (30.12.13).
19 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: POVEDA HERNANDEZ ELISEO. Datos registrales. T 2474 , F 157, S 8, H A 2402, I/A 11 ( 8.06.12).
20 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: POVEDA FERRANDIZ FRANCISO;POVEDA FERRANDIZ JUAN MIGUEL. Nombramientos. Adm.Unico: POVEDA FERRANDIZ JUAN MIGUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2474 , F 157, S 8, H A 2402, I/A 10 ( 7.03.12).
26 de Octubre de 2010Reelecciones. Auditor: PRIETO PASTOR JOSE LUIS. Datos registrales. T 2474 , F 157, S 8, H A 2402, I/A 9 (14.10.10).