Buscador CIF Logo

Actos BORME Pferd Abrasivos Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pferd Abrasivos Sl

Actos BORME Pferd Abrasivos Sl - B01156298

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Alava para Pferd Abrasivos Sl con CIF B01156298

🔙 Perfil de Pferd Abrasivos Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Alava

Actos BORME de Pferd Abrasivos Sl

02 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. Datos registrales. T 1418 , F 196, S 8, H VI 3988, I/A 30(21.12.22).

23 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. Datos registrales. T 1418 , F 195, S 8, H VI 3988, I/A 29 (9.01.20).

16 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apoderado: YAGUE LOPEZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 1418 , F 195, S 8, H VI 3988, I/A 28 ( 5.03.18).

23 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: BERMEOSOLO VICINAY MARIA TERESA. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SANCHEZ JOSEIGNACIO;BORCHERS GARATE ALBERTO;ANDREAS MICHALEC JACEK;YAGUE LOPEZ JUAN IGNACIO;FERNANDEZ DEBARRENA GARCIA GABRIEL. Datos registrales. T 1418 , F 194, S 8, H VI 3988, I/A 27 ( 7.02.18).

16 de Enero de 2018
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del RegistroMercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2016 mediante certificacion del organo de administracion. Datosregistrales. T 1418 , F 193, S 8, H VI 3988, I/A 26 (21.12.17).

02 de Febrero de 2017
Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. Datos registrales. T 1418 , F 193, S 8, H VI 3988, I/A25 (13.01.17).

13 de Diciembre de 2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1418 , F 193, S 8, H VI 3988, I/A 24 (23.11.16).

16 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO;ANDREAS MICHALEC JACEK. Datos registrales. T 1418 , F191, S 8, H VI 3988, I/A 22 ( 2.11.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO;BORCHERS GARATE ALBERTO;BERMEOSOLO VICINAYMARIA TERESA;ANDREAS MICHALEC JACEK. Datos registrales. T 1418 , F 192, S 8, H VI 3988, I/A 23 ( 2.11.16).

18 de Octubre de 2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1418 , F 191, S 8, H VI 3988, I/A 21 (29.09.16).

06 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: MANZANO MARTINEZ URBANO. Apo.Sol.: MANZANO MARTINEZ URBANO. Datos registrales. T1418 , F 191, S 8, H VI 3988, I/A 20 (21.09.16).

27 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: VICENTE DEL REY FERNANDO. Aud.Supl.: MOORE STEPHENS AMS SL. Datos registrales. T 1418 , F190, S 8, H VI 3988, I/A 19 (12.08.15).

06 de Mayo de 2013
Reelecciones. Auditor: VICENTE DEL REY FERNANDO. Aud.Supl.: MOORE STEPHENS AMS SL. Datos registrales. T 1418 , F190, S 8, H VI 3988, I/A 18 (13.04.13).

08 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: RUGGEBERG JIM. Datos registrales. T 1418 , F 190, S 8, H VI 3988, I/A 17 (19.10.12).

13 de Septiembre de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO;BORCHERS GARATE ALBERTO;BERMEOSOLO VICINAYMARIA TERESA. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO;MANZANO MARTINEZ

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ SANCHEZ JOSEIGNACIO;MANZANO MARTINEZ URBANO. Datos registrales. T 1418 , F 189, S 8, H VI 3988, I/A 16 (21.07.12).

24 de Julio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: BERMEOSOLO VICINAY MARIA TERESA;BORCHERS GARATE ALBERTO. Datos registrales. T 1418, F 188, S 8, H VI 3988, I/A 14 (10.07.12).

24 de Febrero de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: ARTECHE VELASCO ALBERTO. Apoderado: ARTECHE VELASCO ALBERTO. Datos registrales. T1418 , F 187, S 8, H VI 3988, I/A 13 (10.02.12).

06 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Aud.Supl.: MOORE STEPHENS AMS SL. Reelecciones. Auditor: VICENTE DEL REY FERNANDO. Datosregistrales. T 1418 , F 187, S 8, H VI 3988, I/A 12 (22.10.09).

30 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: BIELENBERG JORN;RUGGEBERG JIM. Datos registrales. T 667 , F 88, S 8, H VI 3988, I/A 9(13.03.09).

Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO;ARTECHE VELASCO ALBERTO;BORCHERS GARATEALBERTO;BERMEOSOLO VICINAY MARIA TERESA. Datos registrales. T 667 , F 89, S 8, H VI 3988, I/A 10 (13.03.09).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO;ARTECHE VELASCO ALBERTO. Datos registrales. T 1418 ,F 187, S 8, H VI 3988, I/A 11 (13.03.09).

13 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apoderado: RAINER RUHLAND KLAPPERT;MONTOYA ORTIZ ZARATE JOSE RAMON;GONZALEZ SANCHEZIGNACIOApo.Manc.: RUHLAND KLAPPERT RAINER;GONZALEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO;BORCHERS GARATE ALBERTO.Apoderado: FERNANDEZ APELLANIZ INOCENTE EPIFANIO. Datos registrales. T 667 , F 88, S 8, H VI 3988, I/A 8 (19.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información