Actos BORME de Pg111 Project Sl
14 de Febrero de 2023Nombramientos. APOD.MANCOMU: MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON;BONO CRUZ JORDI;VENANCIOFILLAT ENRIQUE;FISAS PUJOL SOLIANO LUCIA. Datos registrales. T 46359 , F 125, S 8, H B 457748, I/A 31 ( 6.02.23).
26 de Julio de 2022Revocaciones. APOD.SOL/MAN: ALIE ZANINI EDUARD. Datos registrales. T 46359 , F 125, S 8, H B 457748, I/A 30 (18.07.22).
28 de Septiembre de 2021Nombramientos. APOD.MANCOMU: MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON;BONO CRUZ JORDI;VENANCIOFILLAT ENRIQUE. Datos registrales. T 46359 , F 124, S 8, H B 457748, I/A 29 (20.09.21).
13 de Octubre de 2020Nombramientos. APODERAD.SOL: VENANCIO FILLAT ENRIQUE;FISAS PUJOL SOLIANO LUCIA. Datos registrales. T 46359 , F124, S 8, H B 457748, I/A 28 ( 2.10.20).
16 de Agosto de 2019Revocaciones. APOD.MANCOMU: CAJA SAMBOAL ESTEBAN. Datos registrales. T 46359 , F 124, S 8, H B 457748, I/A 27 (5.08.19).
07 de Mayo de 2019Revocaciones. CONSEJERO: CAJA SAMBOAL ESTEBAN. VICEPRESIDEN: CAJA SAMBOAL ESTEBAN. Nombramientos.CONSEJERO: GARCIA COLLADO OSCAR. Datos registrales. T 46359 , F 124, S 8, H B 457748, I/A 26 (25.04.19).
21 de Febrero de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 25.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 606.276,00 Euros. Datos registrales. T 46359 , F 123, S 8, HB 457748, I/A 25 (13.02.19).
24 de Diciembre de 2018Otros conceptos: CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO, PASANDO A DENOMINARSE: KKHPROPERTY INVESTORS S.L. Datos registrales. T 46359 , F 123, S 8, H B 457748, I/A 24 (13.12.18).
23 de Noviembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 581.276,00 Euros. Datos registrales. T 46359 , F 122, S 8, HB 457748, I/A 23 (15.11.18).
01 de Junio de 2018Revocaciones. SECR.NO CONS: PEREZ RIVARES JUAN ANTONIO. Nombramientos. SECR.NO CONS: SEGURA DELASSALETTA RAIMUNDO. Datos registrales. T 46359 , F 122, S 8, H B 457748, I/A 22 (24.05.18).
23 de Mayo de 2018Otros conceptos: MODIFICACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE IDENTIDAD DEL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD, PASANDOA DENOMINARSE: KKH PROPERTY INVESTORS HOLDING S.L. Datos registrales. T 46359 , F 122, S 8, H B 457748, I/A 21(16.05.18).
19 de Abril de 2018Nombramientos. VICEPRESIDEN: CAJA SAMBOAL ESTEBAN. Datos registrales. T 44493 , F 128, S 8, H B 457748, I/A 18(10.04.18).
Revocaciones. CONSEJERO: JIMENEZ ZORRILLA ANDRES GUILLERMO. PRESIDENTE: JIMENEZ ZORRILLA ANDRESGUILLERMO. Nombramientos. CONSEJERO: MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON. PRESIDENTE: MANZANAROFERNANDEZ MONTES JUAN RAMON. Datos registrales. T 44493 , F 128, S 8, H B 457748, I/A 19 (10.04.18).
Revocaciones. APOD.MANCOMU: JIMENEZ ZORRILLA ANDRES GUILLERMO. Nombramientos. APOD.MANCOMU: CAJASAMBOAL ESTEBAN. Datos registrales. T 46359 , F 121, S 8, H B 457748, I/A 20 (10.04.18).
01 de Febrero de 2018Revocaciones. CONSEJERO: MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON. VICEPRESIDEN: MANZANARO FERNANDEZMONTES JUAN RAMON. Nombramientos. CONSEJERO: CAJA SAMBOAL ESTEBAN. Datos registrales. T 44493 , F 128, S 8, HB 457748, I/A 17 (24.01.18).
16 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 561.276,00 Euros. Datos registrales. T 44493 , F 127, S 8, HB 457748, I/A 16 ( 5.01.18).
04 de Septiembre de 2017Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL, NUMERO 640, PLANTA 4, LETRA D (BARCELONA). Datos registrales. T 44493 , F127, S 8, H B 457748, I/A 15 (23.08.17).
17 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 57.676,00 Euros. Resultante Suscrito: 551.276,00 Euros. Datos registrales. T 44493 , F 127, S 8, HB 457748, I/A 14 (10.02.17).
24 de Noviembre de 2016Nombramientos. VICEPRESIDEN: MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON. VICESECRET.: BONO CRUZ JORDI.Datos registrales. T 44493 , F 126, S 8, H B 457748, I/A 12 (16.11.16).
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 23.- EL ACTA DE LA JUNTA. ARTICULO 30.- DESIGNACION DE CARGOS EN ELCONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 44493 , F 126, S 8, H B 457748, I/A 13 (16.11.16).
25 de Octubre de 2016Revocaciones. APOD.SOL/MAN: BONO CRUZ JORDI. APOD.MANCOMU: ALIE ZANINI EDUARD;SANCHEZ JULIAN LOLA.APOD.SOL/MAN: JIMENEZ ZORRILLA ANDRES GUILLERMO. APOD.MANCOMU: MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUANRAMON;CAJA SAMBOAL ESTEBAN. Nombramientos. APOD.MANCOMU: JIMENEZ ZORRILLA ANDRESGUILLERMO;MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON;VENANCIO FILLAT ENRIQUE. APOD.SOL/MAN: ALIE ZANINIEDUARD. APOD.MANCOMU: SANCHEZ JULIAN MARIA DOLORES;FISAS PUJOL SOLIANO LUCIA;BONO CRUZ JORDI. Datosregistrales. T 44493 , F 125, S 8, H B 457748, I/A 11 (14.10.16).
12 de Mayo de 2015Otros conceptos: CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO,EN ADELANTE DENOMINADO: KKHPROPERTY INVESTORS BV. Datos registrales. T 44493 , F 125, S 8, H B 457748, I/A 10 ( 5.05.15).
09 de Diciembre de 2014Modificaciones estatutarias. ART.8: TRANSMISIONES FORZOSAS Y MORTIS CAUSA DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Datosregistrales. T 44493 , F 124, S 8, H B 457748, I/A 9 (28.11.14).
17 de Octubre de 2014Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.640 P.5 PTA.B (BARCELONA). Datos registrales. T 44493 , F 124, S 8, H B457748, I/A 8 ( 9.10.14).
25 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: JIMENEZ ZORRILLA ANDRES GUILLERMO;MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUANRAMON. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Consejero: JIMENEZ ZORRILLA ANDRES GUILLERMO. Presidente:JIMENEZ ZORRILLA ANDRES GUILLERMO. Consejero: MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON;BONO CRUZ JORDI.SecreNoConsj: PEREZ RIVARES JUAN ANTONIO. Apo.Sol.: BONO CRUZ JORDI;ALIE ZANINI EDUARDO;SANCHEZ JULIANLOLA;JIMENEZ ZORRILLA ANDRES GUILLERMO;MANZANARO FERNANDEZ MONTES JUAN RAMON;CAJA SAMBOALESTEBAN. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2潞, 22潞, 24潞, 30潞 Y 31潞 Y REFUNDICION DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 32148 , F 15, S 8, H M 578529, I/A 7 (18.09.14).
05 de Agosto de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 490.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 493.600,00 Euros. Datos registrales. T 32148 , F 14, S 8, HM 578529, I/A 6 (28.07.14).