Actos BORME de Photosolar Medina 3 Sl
01 de Junio de 2023Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 - PLANTA 7陋 (MADRID). Datos registrales. T 39236 , F 66, S 8, H M449036, I/A 27 (25.05.23).
29 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: REN YAOKUN. Nombramientos. Adm. Mancom.: WAN MING. Datos registrales. T 39236 , F66, S 8, H M 449036, I/A 26 (22.03.23).
22 de Diciembre de 2022P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Nombramientos. Adm. Mancom.: XING XIANGJUN. Reelecciones. Adm. Mancom.:YUANJIE TANG;REN YAOKUN. Modificaciones estatutarias. DESDOBLAMIENTO DEL NUMERO DE PARTICIPACIONES ENQUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE LA REDUCCION DEL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACION SOCIAL.MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 5. Acciones/Participaciones.-. APROBACION DE TEXTOREFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CTG ZENER SL. Datosregistrales. T 39236 , F 56, S 8, H M 449036, I/A 25 (15.12.22).
09 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39236 , F 56, S 8, H M 449036,I/A 24 (30.11.22).
02 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: JIANG YICHEN. Nombramientos. Apoderado: ZHANG CONGZHENG. Datos registrales. T 39236 , F56, S 8, H M 449036, I/A 23 (25.11.22).
17 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO;CHENGHUA GUAN. Nombramientos. Adm. Mancom.:YUANJIE TANG;REN YAOKUN. Datos registrales. T 39236 , F 55, S 8, H M 449036, I/A 22 ( 9.08.22).
28 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ZHOU SHENG LEI WANG;MATEOS FERNANDEZ-VILLA ISABEL;ORTEGA MORO CLARA. Datosregistrales. T 39236 , F 55, S 8, H M 449036, I/A 21 (20.07.22).
11 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: HERRERO RUIZ IGNACIO;YUANJIE TANG. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIARODRIGUEZ JOSE BENITO;CHENGHUA GUAN. Datos registrales. T 39236 , F 54, S 8, H M 449036, I/A 19 ( 4.02.22).
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 67 6陋 (MADRID). Datos registrales. T 39236 , F 55, S 8, H M 449036, I/A 20 ( 4.02.22).
23 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: X-ELIO ENERGY SL. Representan: NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS. Revocaciones. Apoderado:MONFORT CELDRAN JOAQUIN;DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE;MARTINEZNAVARRO MARIA ARANZAZU;PARDO AYUSO JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Mancom.: HERRERO RUIZIGNACIO;YUANJIE TANG. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoresmancomunados. Cambio de domicilio social. C/ PRADILLO 5 BAJO (MADRID). Datos registrales. T 39236 , F 54, S 8, H M449036, I/A 18 (16.02.21).
18 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: HERRERO RUIZ IGNACIO;TANG YUANJIE;GUAN CHENGHUA;JIANG YICHEN. Datos registrales. T39236 , F 52, S 8, H M 449036, I/A 17 (11.02.21).
15 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: PARADISO BENIAMINO. Datos registrales. T 39236 , F 52, S 8, H M 449036, I/A 16 ( 7.10.20).
30 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Representan: NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS.Datos registrales. T 39236 , F 51, S 8, H M 449036, I/A 15 (23.04.20).
27 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ POETA JOAN MARAGALL 1 5 (MADRID). Datos registrales. T 39236 , F 51, S 8, H M 449036, I/A14 (20.04.20).
03 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIOENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;PARDO AYUSO JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 24937 , F 164, S 8, H
22 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE;BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Adm. Unico: GESTAMPASETYM SOLAR SL. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejode administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 24937 , F 164, S 8, H M 449036, I/A 12 (11.05.17).
04 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Consejero: RIBERAS MERA JUAN MARIA;RIBERAS MERAFRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: RIBERAS MERA JUAN MARIA. Presidente: RIBERAS MERA JUAN MARIA. Secretario: RIBERASMERA FRANCISCO JOSE. Consejero: BARREDO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 24937 , F 164, S 8, H M 449036, I/A 11(27.01.16).
23 de Mayo de 2011Cambio de domicilio social. C/ OMBU NUMERO 3, PLANTA 2& (MADRID). Datos registrales. T 24937 , F 164, S 8, H M 449036,I/A 10 (12.05.11).
19 de Enero de 2010Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificada la fecha del cierre del ejercicio social y modificado el articulo 5 delos estatutos. Datos registrales. T 24937 , F 163, S 8, H M 449036, I/A 9 ( 7.01.10).
16 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 24937 , F 162, S 8, H M 449036, I/A 8 (27.08.09).
04 de Mayo de 2009Cambio de objeto social. EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES, PRINCIPALMENTE DE ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA, EN CUALQUIERA DE SUS FASES... Datos registrales. T 24937 , F 162, S 8, H M 449036, I/A 7(21.04.09).
03 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ENCINAS ROMAN EMILIO. Nombramientos. Consejero: BARREDO LOPEZ JORGE. Datosregistrales. T 24937 , F 162, S 8, H M 449036, I/A 6 (24.03.09).
02 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 24937 , F 161, S 8, H M 449036, I/A 5 (24.03.09).