Actos BORME de Pimpenus Itg Sl
18 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 44075 , F 186, S 8, H M 677630, I/A 27(11.12.23).
Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 44075 , F 187, S 8, H M 677630, I/A 28(11.12.23).
23 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FORMALIZACION Y GESTION SL. Datos registrales. T 44075 , F 186, S 8, H M 677630, I/A 26(16.01.23).
23 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ OBREGON SARA;MORENO CEBALLOS DAVID. Datos registrales. T 40543 , F 225, S 8, H M677630, I/A 23 (17.12.22).
Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 40543 , F 225, S 8, H M 677630, I/A 24(17.12.22).
Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 44075 , F 184, S 8, H M 677630, I/A 25(17.12.22).
29 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FONTES DE CASTRO LUCIA;RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR;MORALES CENTENERABLANCA;HIPOGES IBERIA SL. Nombramientos. Apoderado: HIPOGES IBERIA SL;LOZANO FERNANDEZ HECTOR. Datosregistrales. T 40543 , F 223, S 8, H M 677630, I/A 22 (22.11.22).
27 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: VELILLA DIEZ JACOBO;MONTES FERNANDEZ CLAUDIA;ESPERON CAMPOS RAMSES;ALONSOMARTIN ANDRES. Datos registrales. T 40543 , F 223, S 8, H M 677630, I/A 21 (20.09.22).
06 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: HIPOGES IBERIA SL. Datos registrales. T 40543 , F 221, S 8, H M 677630, I/A 20 (30.03.22).
04 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: GONCALVES MARIANA MITTEL. Datos registrales. T 40543 , F 118, S 8, H M 677630, I/A 17(28.01.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: MONTORO GAMARRO JAIME;ARRIBAS ALEJANDRO DAVID;MACIAS GARCIA OLGA;NAVARROGONZALEZ MARIA TERESA;VASQUEZ OLIVEIRA CARLA CORINA;BLANCO BETEGON CLARA MARIA;COSANO MATEOSFRANCISCO JAVIER;GOODING GEITHNER HANS. Datos registrales. T 40543 , F 118, S 8, H M 677630, I/A 18 (28.01.22).
Nombramientos. Apoderado: FORMALIZACION Y GESTION SL. Datos registrales. T 40543 , F 119, S 8, H M 677630, I/A 19(28.01.22).
14 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 40543 , F 115, S 8, H M 677630, I/A 15 (3.12.21).
Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 40543 , F 117, S 8, H M 677630, I/A 16 (3.12.21).
22 de Octubre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SANDI ASSETS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. Datosregistrales. T 40543 , F 115, S 8, H M 677630, I/A 14 (15.10.21).
01 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ OBREGON SARA;CARVALHO VELEZ HUGO REINALDO. Datos registrales. T 40543 , F112, S 8, H M 677630, I/A 12 (24.09.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES CENTENERA BLANCA;LINARES VIZCAINO BEATRIZ. Datos registrales. T 40543 , F 115,S 8, H M 677630, I/A 13 (24.09.21).
30 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CARVALHO VELEZ HUGO REINALDO;CASALEIRO GODINHO NUNO GONCALO.Nombramientos. Adm. Unico: DUXBURY SPAIN SL. Representan: CASALEIRO GODINHO NUNO GONCALO. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 40543 , F 112, S8, H M 677630, I/A 11 (23.09.21).
27 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 38066 , F 14, S 8, H M 677630, I/A 9(20.08.20).
Nombramientos. Apoderado: PEPPER SPANISH SERVICING SL. Datos registrales. T 38066 , F 14, S 8, H M 677630, I/A 10(20.08.20).
09 de Junio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ OBREGON SARA;MORENO CEBALLOS DAVID. Datos registrales. T 38066 , F 13, S 8, H M677630, I/A 8 ( 2.06.20).
04 de Junio de 2020Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11. Datos registrales. T 38066 , F 13, S 8, H M 677630, I/A 7(28.05.20).
13 de Diciembre de 2019Modificaciones estatutarias. Se modifica el articulo 8 de los estatutos sociales y creacion del apartado 7.5 . Datos registrales. T38066 , F 12, S 8, H M 677630, I/A 6 ( 5.12.19).
07 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DUXBURY SPAIN SL. Representan: PANUNZIO CLAUDIO. Nombramientos. Adm. Mancom.:CARVALHO VELEZ HUGO REINALDO;CASALEIRO GODINHO NUNO GONCALO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 38066 , F 12, S 8, H M 677630, I/A 5(30.09.19).
05 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: FONTES DE CASTRO LUCIA;RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR;MORALES CENTENERABLANCA;HIPOGES IBERIA SL. Datos registrales. T 38066 , F 10, S 8, H M 677630, I/A 4 (28.06.19).
20 de Marzo de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: DUXBURY SPAIN SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:INTERTRUST (SPAIN) SL. Representan: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Nombramientos. Adm. Unico: DUXBURY SPAIN SL.Representan: PANUNZIO CLAUDIO. Cambio de domicilio social. C/ ALBACETE 3 - 5陋 PLANTA (MADRID). Cambio de objetosocial. LA CONSTITUCION, PARTICIPACION POR SI MISMA O DE FORMA INDIRECTA LA GESTION Y CONTROL DE OTRASEMPRESAS Y SOCIEDADES. Datos registrales. T 38066 , F 7, S 8, H M 677630, I/A 2 (13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: HIPOGES IBERIA SL. Apo.Sol.: FONTES DE CASTRO LUCIA;PEREZ OBREGON SARA;PEREDOPEREZ ALVARO;MORALES CENTENERA BLANCA;MORALES VILLANUEVA PALOMA. Datos registrales. T 38066 , F 7, S 8, H M677630, I/A 3 (13.03.19).
18 de Septiembre de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.04.18. Objeto social: 1. La adquisici贸n, tenencia, disfrute y administraci贸n, direcci贸n ygesti贸n de t铆tulos valores y/o acciones no sujetas a negociaci贸n y/o participaciones sociales representativas de los fondos propios desociedades o entidades constituidas en territorio espa帽ol... Domicilio: C/ SERRANO 41 4潞 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros.Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INTERTRUST (SPAIN) SL. Nombramientos. Representan: ROZPIDE ORBEGOZOCARMEN. Adm. Unico: INTERTRUST (SPAIN) SL. Datos registrales. T 38066 , F 4, S 8, H M 677630, I/A 1 ( 3.09.18).