Actos BORME de Piquero Gutierrez Sociedad Limitada
03 de Enero de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: PIQUERO PASCUAL JESUS;PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT;PIQUERO MARTINEZ JOSEMANUEL. Datos registrales. T 3928 , F 81, S 8, H Z 53759, I/A 10 (28.12.21).
04 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERO GUTIERREZ JESUS. Con.Delegado: PASCUAL SERRANO PILAR. Secretario: PIQUEROGUTIERREZ JESUS. Nombramientos. Secretario: PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT. Reelecciones. Presidente: PIQUEROMARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3928 , F 80, S 8, H Z 53759, I/A 9 (28.07.20).
15 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: PIQUERO PASCUAL JESUS. Datos registrales. T 3928 , F 79, S 8, H Z 53759, I/A 8 ( 8.01.19).
22 de Mayo de 2015Modificaciones estatutarias. "Art铆culo decimonoveno. Car谩cter retribuido del cargo de administrador. El cargo de Administrador esretribuido. La retribuci贸n ser谩 una asignaci贸n fija anual que acuerde la Junta General y que permanecer谩 vigente en tanto no seapruebe su modificaci贸n". . Datos registrales. T 3928 , F 79, S 8, H Z 53759, I/A 7 (13.05.15).
29 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERO GUTIERREZ JOSE MARIA. Presidente: PIQUERO GUTIERREZ JOSE MARIA.Nombramientos. Consejero: PIQUERO MARTINEZ JOSE MARIA;PIQUERO PASCUAL JESUS;PIQUERO MARTINEZ JOSEMANUEL;PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT. Presidente: PIQUERO MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3928 , F 79, S8, H Z 53759, I/A 6 (21.07.14).
29 de Julio de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 466.360,00 Euros. Datos registrales. T 3928 , F 79, S 8, H Z53759, I/A 5 (19.07.13).
08 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: PIQUERO MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 3928 , F 77, S 8, H Z 53759, I/A 2(26.10.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT;PIQUERO MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T3928 , F 78, S 8, H Z 53759, I/A 3 (26.10.12).
Nombramientos. Apoderado: PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT. Datos registrales. T 3928 , F 78, S 8, H Z 53759, I/A 4(26.10.12).
07 de Noviembre de 2012Nombramientos. Con.Delegado: PASCUAL SERRANO PILAR. Datos registrales. T 3928 , F 76, S 8, H Z 53759, I/A 1 (12.09.12).
24 de Septiembre de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.07.12. Objeto social: La compra, venta, permuta, construcci贸n, rehabilitaci贸n, reforma,transformaci贸n, urbanizaci贸n, arrendamiento no financiero y explotaci贸n de toda clase de inmuebles r煤sticos o urbanos,comprendiendo la construcci贸n bajo cualquier formula de edificios conteniendo bloques o apartamentos, naves agr铆col. Domicilio:PLAZA EL FUERTE 7 - BAJO (CALATAYUD). Capital: 464.360,00 Euros. Nombramientos. Consejero: PIQUERO GUTIERREZJOSE MARIA;MARTINEZ GARCIA MARIA TERESA;PIQUERO GUTIERREZ JESUS;PASCUAL SERRANO PILAR. Presidente: