Buscador CIF Logo

Actos BORME Piquero Gutierrez Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Piquero Gutierrez Sociedad Limitada

Actos BORME Piquero Gutierrez Sociedad Limitada - B99351678

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Piquero Gutierrez Sociedad Limitada con CIF B99351678

馃敊 Perfil de Piquero Gutierrez Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Piquero Gutierrez Sociedad Limitada

03 de Enero de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: PIQUERO PASCUAL JESUS;PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT;PIQUERO MARTINEZ JOSEMANUEL. Datos registrales. T 3928 , F 81, S 8, H Z 53759, I/A 10 (28.12.21).

04 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERO GUTIERREZ JESUS. Con.Delegado: PASCUAL SERRANO PILAR. Secretario: PIQUEROGUTIERREZ JESUS. Nombramientos. Secretario: PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT. Reelecciones. Presidente: PIQUEROMARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3928 , F 80, S 8, H Z 53759, I/A 9 (28.07.20).

15 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: PIQUERO PASCUAL JESUS. Datos registrales. T 3928 , F 79, S 8, H Z 53759, I/A 8 ( 8.01.19).

22 de Mayo de 2015
Modificaciones estatutarias. "Art铆culo decimonoveno. Car谩cter retribuido del cargo de administrador. El cargo de Administrador esretribuido. La retribuci贸n ser谩 una asignaci贸n fija anual que acuerde la Junta General y que permanecer谩 vigente en tanto no seapruebe su modificaci贸n". . Datos registrales. T 3928 , F 79, S 8, H Z 53759, I/A 7 (13.05.15).

29 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERO GUTIERREZ JOSE MARIA. Presidente: PIQUERO GUTIERREZ JOSE MARIA.Nombramientos. Consejero: PIQUERO MARTINEZ JOSE MARIA;PIQUERO PASCUAL JESUS;PIQUERO MARTINEZ JOSEMANUEL;PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT. Presidente: PIQUERO MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3928 , F 79, S8, H Z 53759, I/A 6 (21.07.14).

29 de Julio de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 466.360,00 Euros. Datos registrales. T 3928 , F 79, S 8, H Z53759, I/A 5 (19.07.13).

08 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: PIQUERO MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 3928 , F 77, S 8, H Z 53759, I/A 2(26.10.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT;PIQUERO MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T3928 , F 78, S 8, H Z 53759, I/A 3 (26.10.12).

Nombramientos. Apoderado: PIQUERO PASCUAL MONTSERRAT. Datos registrales. T 3928 , F 78, S 8, H Z 53759, I/A 4(26.10.12).

07 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Con.Delegado: PASCUAL SERRANO PILAR. Datos registrales. T 3928 , F 76, S 8, H Z 53759, I/A 1 (12.09.12).

24 de Septiembre de 2012
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.07.12. Objeto social: La compra, venta, permuta, construcci贸n, rehabilitaci贸n, reforma,transformaci贸n, urbanizaci贸n, arrendamiento no financiero y explotaci贸n de toda clase de inmuebles r煤sticos o urbanos,comprendiendo la construcci贸n bajo cualquier formula de edificios conteniendo bloques o apartamentos, naves agr铆col. Domicilio:PLAZA EL FUERTE 7 - BAJO (CALATAYUD). Capital: 464.360,00 Euros. Nombramientos. Consejero: PIQUERO GUTIERREZJOSE MARIA;MARTINEZ GARCIA MARIA TERESA;PIQUERO GUTIERREZ JESUS;PASCUAL SERRANO PILAR. Presidente:

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n