Actos BORME de Pirenauto Sociedad Limitada
28 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CALVO PUJOL JUAN JOSE;MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO;BAQUER MASGRAU LUIS.Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Secretario: BAQUER MASGRAU LUIS. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLOLEGUINA PABLO. Revocaciones. Apoderado: LACASA PONCE ANTONIO-MARIO;MU脩OZ SANZ HECTOR. Apo.Sol.: ESTALLOLALIENA EVA;NAVALES MENDOZA RAQUEL. Apoderado: COTO OTO SERGIO-ALBERTO. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 683 , F 49, S 8, H HU 1302, I/A 57 (21.11.22).
26 de Octubre de 2022Otros conceptos: Cesado el Auditor de Cuentas PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL con fecha 30/6/2021. Datosregistrales. T 683 , F 49, S 8, H HU 1302, I/A 56 (22.08.22).
29 de Agosto de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 683 , F 49, S 8, H HU 1302, I/A56 (22.08.22).
17 de Junio de 2021Ampliacion del objeto social. El alquiler de veh铆culos sin conductor, la actividad de toda clase de transporte, la compraventa,representaci贸n y reparaci贸n de autom贸viles de cualquier marca, incluso de camiones, autobuses y de maquinaria industrial y de obras.Datos registrales. T 683 , F 49, S 8, H HU 1302, I/A 55 (10.06.21).
19 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 573 , F 47, S 8, H HU 1302, I/A 53(12.01.21).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 573 , F 47, S 8, H HU 1302, I/A 54(12.01.21).
12 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Secretario: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO.Vicesecret.: CALVO PUJOL JUAN JOSE. Vicepresid.: BAQUER MASGRAU LUIS. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUERIGNACIO. Cons.Del.Sol: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Nombramientos. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINAPABLO. Secretario: BAQUER MASGRAU LUIS. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Datos registrales. T 573 ,F 47, S 8, H HU 1302, I/A 52 ( 2.12.19).
28 de Mayo de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 800.003,12 Euros. Resultante Suscrito: 3.110.391,36 Euros. Datos registrales. T 573 , F 46, S 8, HHU 1302, I/A 51 (21.05.19).
22 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: COTO OTO SERGIO-ALBERTO. Datos registrales. T 573 , F 46, S 8, H HU 1302, I/A 50 (15.01.19).
20 de Diciembre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AUTOMOVILES LA OSCENSE SA. Datos registrales. T 573 , F 46, S 8, H HU1302, I/A 49 (13.12.18).
18 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 573 , F 45, S 8, H HU 1302, I/A 47(10.10.18).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 573 , F 45, S 8, H HU 1302, I/A 48(10.10.18).
08 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: TRESACO CIDON MANUEL. Vicepresid.: TRESACO CIDON MANUEL. Nombramientos.Consejero: BAQUER MASGRAU LUIS. Vicepresid.: BAQUER MASGRAU LUIS. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A46 ( 2.11.17).
11 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A 45 (5.10.16).
23 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: NAVALES MENDOZA RAQUEL. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A 44 (16.05.14).
26 de Septiembre de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Nombramientos.Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A 43 (19.09.13).
05 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: TRESACO CIDON MANUEL. Secretario: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO.Nombramientos. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Secretario: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO.Vicepresid.: TRESACO CIDON MANUEL. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A 42 (29.07.13).
04 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A41 (28.01.13).
26 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A40 (19.12.12).
14 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A39 ( 2.12.11).
18 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: MANZANEDO AGUILAR JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 573 , F 44, S 8, H HU 1302, I/A 38 (9.11.11).
08 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Datos registrales. T 573 , F 43, S 8, H HU 1302, I/A37 (31.08.11).
22 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 488.180,28 Euros. Resultante Suscrito: 2.310.388,24 Euros. Datos registrales. T 573 , F 43, S 8, HHU 1302, I/A 36 (12.11.10).
02 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Datos registrales. T 573 , F 43, S 8, HHU 1302, I/A 35 (22.10.10).
04 de Octubre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ PEREZ JORGE. Datos registrales. T 573 , F 43, S 8, H HU 1302, I/A 34 (24.09.10).
09 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: MANZANEDO AGUILAR JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 508 , F 225, S 8, H HU 1302, I/A 32(26.02.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ PEREZ JORGE. Datos registrales. T 508 , F 225, S 8, H HU 1302, I/A 33 (26.02.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESTALLO LALIENA EVA. Datos registrales. T 508 , F 225, S 8, H HU 1302, I/A 31 (26.02.10).
03 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.007,96 Euros. Resultante Suscrito: 1.822.207,96 Euros. Datos registrales. T 508 , F 224, S 8, HHU 1302, I/A 30 (25.08.09).