Buscador CIF Logo

Actos BORME Pirobloc Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pirobloc Sa

Actos BORME Pirobloc Sa - A08451965

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Pirobloc Sa con CIF A08451965

馃敊 Perfil de Pirobloc Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Pirobloc Sa

21 de Octubre de 2021
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: MONGAY CAZCARRA ANGEL;MONGAY HERNANDO JORDI. Nombramientos. ADM.UNICO:MONGAY HERNANDO JORDI. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA YDETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 20742 , F194, S 8, H B 24286, I/A 32 (14.10.21).

06 de Agosto de 2019
Revocaciones. ADM.UNICO: MONGAY CAZCARRA ANGEL. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MONGAY CAZCARRAANGEL;MONGAY HERNANDO JORDI. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 20742 , F 193, S 8, H B 24286, I/A31 (29.07.19).

18 de Febrero de 2019
Cambio de objeto social. AMPLIAR A:INSTALACION DE TUBERIAS PARA ACEITE TERMICO,VAPOR Y AGUACALIENTE;INSTALACIONES DE GAS,FONTANERIA,CALEFACCION,CLIMATIZACION,SISTEMAS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS,PETROLIFERAS,AIRE COMPRIMIDO,FRIO INDUSTRIAL,ETC. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas:ALLFLUID SL. SOINFLUID SA. Datos registrales. T 8307 , F 103, S 8, H B 24286, I/A 30 ( 7.02.19).

18 de Septiembre de 2017
Revocaciones. APODERADO: VARGAS GARCIA ARMAND. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: VARGAS GARCIAARMAND;FERRER VILLARO CARLOS;MONGAY HERNANDO JORDI. Datos registrales. T 8307 , F 101, S 8, H B 24286, I/A 29 (8.09.17).

13 de Septiembre de 2017
Cambio de domicilio social. CL BLANQUERS, 2, POL. IND. SANTIGA (SANTA PERPETUA DE MOGODA). Datos registrales. T8307 , F 101, S 8, H B 24286, I/A 28 ( 5.09.17).

25 de Noviembre de 2014
Revocaciones. ADM.UNICO: MONGAY CAZCARRA ANGEL. Nombramientos. ADM.UNICO: MONGAY CAZCARRA ANGEL.Datos registrales. T 8307 , F 101, S 8, H B 24286, I/A 27 (14.11.14).

16 de Agosto de 2011
Revocaciones. APODERADO: VARGAS GARCIA ARMAND. Datos registrales. T 8307 , F 100, S 8, H B 24286, I/A 25 ( 3.08.11).

Nombramientos. APODERADO: VARGAS GARCIA ARMAND. Datos registrales. T 8307 , F 100, S 8, H B 24286, I/A 26 ( 3.08.11).

14 de Julio de 2011
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: LAVINIA AUDITORIA AND CONSULTORIA SL. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: RSBAUDITORES ASOCIADOS SLP. Datos registrales. T 8307 , F 99, S 8, H B 24286, I/A 23 ( 1.07.11).

Revocaciones. AUDIT.CUENT.: RSB AUDITORES ASOCIADOS SLP. Datos registrales. T 8307 , F 100, S 8, H B 24286, I/A 24 (1.07.11).

29 de Septiembre de 2009
Cambio de domicilio social. PG INDUSTRIAL SANTIGA AV.CASTELL DE BARBERA Num.31 (BARBERA DEL VALLES). Datosregistrales. T 8307 , F 99, S 8, H B 24286, I/A 22 (17.09.09).

30 de Abril de 2009
Revocaciones. ADM.UNICO: SOLER PALA JOSEP. Nombramientos. ADM.UNICO: MONGAY CAZCARRA ANGEL. Datosregistrales. T 8307 , F 99, S 8, H B 24286, I/A 21 (17.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n