Actos BORME de Pittway Homes Systems Sl
01 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ALONSO BARBAS ALICIA. VsecrNoConsj: PUENTES HERNANDEZ ELSA. Consejero: GARCIABLAZQUEZ ALVARO. Presidente: GARCIA BLAZQUEZ ALVARO. Consejero: ABELLAN-GARCIA BARRIO PATRICIA;GONZALEZADEVA IRENE. Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO;MINGUEZ MARTINNORBERTO ANDRES;FERNANDEZ DE CORDOVA YBA脩EZ AYMAR;GENCHI NICOLA. Apo.Manc.: RAFFELLI PABLOSIMON;YAMANA SRINIVIASA BABU;SATHYANARAYANA SUBBARAMU;NARAYANASWAMY MADHU MAHANANDI;SHARDAREKHA KUMARI;GIRISHANKAR;RAMESH DINESH KUMAR;RENUKAIAH HALASWAMY HIREMATH;CHANDRAGIRISREENIVASULU. Apo.Sol.: CENDAN LASHERAS ANTONIO;SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO. Apoderado:SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO;CENDAN LASHERAS ANTONIO;SAMSON CHRISTOPHE;HANAKOVAGABRIELA;TURHAM DIGIS GUNGOR;MARKONE PECSI KLARA;ZAGANCZYK KRZYSZTOF;MARIA RADU MIHAELA;NGUYENSAYSANAK;PANDURANGAIAH SRINIVAS;VENUGOPAL RAVISHANKAR;SHARDA REKHA;BHATTACHARYA SUDIPTO;DRURYROBERT;LAZZETA VERONICA. Apo.Sol.: GONZALEZ ADEVA IRENE;SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZALVARO;CENDAN LASHERAS ANTONIO. Apoderado: ABELLAN-GARCIA BARRIO PATRICIA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n.Datos registrales. T 38298 , F 8, S 8, H M 673786, I/A 20 (24.11.22).
29 de Abril de 2022Revocaciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 38298 , F 8, S 8, H M 673786, I/A 19 (22.04.22).
14 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 38298 , F 7, S 8, H M 673786, I/A 18 ( 7.01.22).
10 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: BALAGUER PETROVA SONIA. Datos registrales. T 38298 , F 7, S 8, H M 673786, I/A 17 ( 1.12.20).
04 de Diciembre de 2020Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 15陋 el nombramiento como consejero de CENDAN LASHERAS ANTONIO, siendolo correcto su cese el dicho cargo. Datos registrales. T 38298 , F 7, S 8, H M 673786, I/A 15 (26.11.20).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CENDAN LASHERAS ANTONIO. Datos registrales. T 38298 , F 7, S 8, H M 673786, I/A 15(26.11.20).
03 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ SANZ MANUEL. Presidente: SANCHEZ SANZ MANUEL. Nombramientos. Presidente:GARCIA BLAZQUEZ ALVARO. Consejero: CENDAN LASHERAS ANTONIO;ABELLAN-GARCIA BARRIO PATRICIA;GONZALEZADEVA IRENE. Datos registrales. T 38298 , F 7, S 8, H M 673786, I/A 15 (26.11.20).
Cambio de domicilio social. AVDA ITALIA 7 (COSLADA). Datos registrales. T 38298 , F 7, S 8, H M 673786, I/A 16 (26.11.20).
25 de Octubre de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 38298 , F 6, S 8, H M 673786, I/A 14(18.10.19).
25 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: ABELLAN-GARCIA BARRIO PATRICIA. Datos registrales. T 38298 , F 6, S 8, H M 673786, I/A 13(17.07.19).
24 de Abril de 2019Cambio de domicilio social. C/ TITAN 8 - PLANTA 3 (MADRID). Datos registrales. T 38298 , F 5, S 8, H M 673786, I/A 12(15.04.19).
23 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO;CENDAN LASHERAS ANTONIO. Datosregistrales. T 38298 , F 5, S 8, H M 673786, I/A 11 (12.04.19).
22 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: BALAGUER PETROVA SONIA;GONZALEZ ADEVA IRENE. Datos registrales. T 38298 , F 4, S 8, H M673786, I/A 10 (11.04.19).
12 de Marzo de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ADEMCO 4 LIMITED. Datos registrales. T 38298 , F 4, S 8, H M 673786, I/A 9 (5.03.19).
31 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO;CENDAN LASHERAS ANTONIO;SAMSONCHRISTOPHE;HANAKOVA GABRIELA;TURHAM DIGIS GUNGOR;MARKONE PECSI KLARA;ZAGANCZYK KRZYSZTOF;MARIARADU MIHAELA;NGUYEN SAYSANAK;PANDURANGAIAH SRINIVAS;VENUGOPAL RAVISHANKAR;SHARDAREKHA;BHATTACHARYA SUDIPTO;DRURY ROBERT;LAZZETA VERONICA. Datos registrales. T 38298 , F 3, S 8, H M 673786,I/A 8 (21.12.18).
31 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: O'CONNOR BRENDAN PATRICK. Nombramientos. SecreNoConsj: ALONSO BARBAS ALICIA.VsecrNoConsj: PUENTES HERNANDEZ ELSA. Consejero: SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO;CENDANLASHERAS ANTONIO. Presidente: SANCHEZ SANZ MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 38298 , F 2, S 8, H M 673786, I/A 7 (24.10.18).
30 de Octubre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.000,00 Euros. Datos registrales. T 37827 , F 7, S 8, H M673786, I/A 6 (22.10.18).
15 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO. Datos registrales. T 37827 , F 4, S 8, H M673786, I/A 2 ( 4.10.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: MINGUEZ MARTIN NORBERTO ANDRES;FERNANDEZ DE CORDOVA YBA脩EZ AYMAR;GENCHINICOLA. Datos registrales. T 37827 , F 5, S 8, H M 673786, I/A 3 ( 4.10.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: RAFFELLI PABLO SIMON;YAMANA SRINIVIASA BABU;SATHYANARAYANASUBBARAMU;NARAYANASWAMY MADHU MAHANANDI;SHARDA REKHA KUMARI;GIRISHANKAR;RAMESH DINESHKUMAR;RENUKAIAH HALASWAMY HIREMATH;CHANDRAGIRI SREENIVASULU. Datos registrales. T 37827 , F 6, S 8, H M673786, I/A 4 ( 4.10.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: CENDAN LASHERAS ANTONIO;SANCHEZ SANZ MANUEL;GARCIA BLAZQUEZ ALVARO. Datosregistrales. T 37827 , F 7, S 8, H M 673786, I/A 5 ( 4.10.18).
27 de Junio de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.05.18. Objeto social: - La provisi贸n de productos, soluciones y tecnolog铆as para el controlde la eficiencia energ茅tica residencial, seguridad y vigilancia, con una cartera de dispositivos y software conectados, as铆 como ladistribuci贸n mayorista de productos de seguridad y baja tensi贸n. - La adquisici贸n, tenencia, ... Domicilio: C/ JOSEFA VALCARCEL 27(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: O'CONNOR BRENDAN PATRICK. Datos registrales. T 37827 ,F 1, S 8, H M 673786, I/A 1 (20.06.18).